Extract for the legal entity DER Touristik CZ a.s. (IČO: 45312974)

Date and time of the extract: 14 Dec 2025, 08:19 (Prague time)*
NEW SEARCH

Basic information

Company name: DER Touristik CZ a.s. (from 1 Jun 2021)
- Previous name - EXIM TOURS a.s. (from 20 Feb 2002 to 1 Jun 2021)
- Previous name - "EXIM TOURS spol. s r.o." (from 28 Jan 1998 to 20 Feb 2002)
- Previous name - EXIM spol. s r.o. (from 30 Apr 1992 to 28 Jan 1998)
Registration number (IČO): 45312974
Tax identification number (Tax ID, "DIČ" in Czech): CZ45312974
Date of establishment/registration: 30 Apr 1992
- Registration number (IČO), tax ID (DIČ) and registration date are permanent data of the Czech legal entity and do not change
Legal address: Česká republika, Praha, Babákova 2390/2, Chodov, 14800 Praha 4 (from 7 Nov 2017)
- Previously - Česká republika, Praha, Revoluční 1044/23, Staré Město, 11000 Praha 1 (from 16 Nov 2016 to 7 Nov 2017)
- Previously - Česká republika, Praha, Revoluční 1044/23, Staré Město, 11000 Praha 1 (from 28 Jan 1998 to 16 Nov 2016)
- Previously - Česká republika, Praha, Sokolovská 468/116, Karlín, 18600 Praha 8 (from 30 Apr 1992 to 28 Jan 1998)
Share capital: 12 000 000 Czech crowns , paid on 100 percents (from 20 Feb 2002)
- Previously - 100 000 Czech crowns (from 26 Nov 1993 to 20 Feb 2002)
Legal form: Joint-stock company, stock corporation ("a.s.") (from 20 Feb 2002)
- Previously - Limited liability company (s.r.o.) (from 30 Apr 1992 to 20 Feb 2002)
Company status (Good standing): Legal entity is active
- Tracking changes to the company's status is very hard – please refer to the notes on company name changes for clarity.
Registering authority: Court MSPH, section B, archive number 7557 (from 20 Feb 2002)
- Previously - Court MSPH, section C, archive number 9241 (from 30 Apr 1992 to 20 Feb 2002) ;

Governing bodies and their representatives (current, active)

In the sections below, you will find information about the currently active governing bodies of the legal entity DER Touristik CZ a.s. and the appointed representatives in each body.

Managing board (Představenstvo), current representatives

Number of members in this governing body currently defined by the charter: 3 (from 1 Sep 2020)
- Previously - number of members: 3 (from 13 Aug 2015 to 1 Sep 2020)
Name: LUKÁŠ MATĚJKA
Registration address: Česká republika, Police nad Metují, Fučíkova 325, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Sep 2025
Recorded in the Trade Register: 30 Oct 2025
Name: JIŘÍ JELÍNEK
Registration address: Česká republika, Mnichovice, U studánky 120, Myšlín, 25164 Mnichovice
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 1 Sep 2025
Recorded in the Trade Register: 30 Oct 2025
Name: JOLANA ZAVADILOVÁ
Registration address: Česká republika, Praha, Na břehu 260/1, Vysočany, 19000 Praha 9
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Sep 2025
Recorded in the Trade Register: 30 Oct 2025
Name: ROMANA SLÍŽKOVÁ
Registration address: Česká republika, Libeř, č.p. 217, 25241 Libeř
Position in the governing body: místopředseda představenstva
Appointment date: 1 Sep 2025
Recorded in the Trade Register: 30 Oct 2025

Authority to represent the legal entity

How members of this governing body can currently represent the legal entity:
  • Za Společnost jednají vůči třetím stranám vždy 2 členové představenstva společně s tím, že vždy podepisuje buď předseda anebo místopředseda představenstva. (from 1 Sep 2020)

Managing board (Představenstvo), history of changes

Below, you will find the representatives of the Managing board (Představenstvo), who were previously appointed, as well as changes to their details.

Name: ROMANA SLÍŽKOVÁ
Registration address: Česká republika, Libeř, č.p. 217, 25241 Libeř
Position in the governing body: místopředseda představenstva
Appointment date: 1 Sep 2020
Date of termination from office: 1 Sep 2025
Recorded in the Trade Register: 1 Sep 2020
Deleted from the Trade Register: 30 Oct 2025
Name: JAN KŘÍŽ
Registration address: Česká republika, Praha, Stojická 882/2b, Vinoř, 19017 Praha 9
Position in the governing body: Člen představenstva
Appointment date: 1 Sep 2020
Date of termination from office: 31 Aug 2023
Recorded in the Trade Register: 1 Sep 2020
Deleted from the Trade Register: 12 Oct 2023
Name: JOLANA ZAVADILOVÁ
Registration address: Česká republika, Praha, Na břehu 260/1, Vysočany, 19000 Praha 9
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Sep 2020
Date of termination from office: 1 Sep 2025
Recorded in the Trade Register: 1 Sep 2020
Deleted from the Trade Register: 30 Oct 2025
Name: LUKÁŠ MATĚJKA
Registration address: Česká republika, Police nad Metují, Fučíkova 325, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Sep 2020
Date of termination from office: 1 Sep 2025
Recorded in the Trade Register: 1 Sep 2020
Deleted from the Trade Register: 30 Oct 2025
Name: JIŘÍ JELÍNEK
Registration address: Česká republika, Mnichovice, U studánky 120, Myšlín, 25164 Mnichovice
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 1 Sep 2020
Date of termination from office: 1 Sep 2025
Recorded in the Trade Register: 1 Sep 2020
Deleted from the Trade Register: 30 Oct 2025
Name: JAN KŘÍŽ
Registration address: Česká republika, Praha, Stojická 882/2b, Vinoř, 19017 Praha 9
Position in the governing body: Člen představenstva
Appointment date: 1 Aug 2017
Recorded in the Trade Register: 7 Nov 2017
Deleted from the Trade Register: 1 Sep 2020
Name: LADISLAV KRÁL
Registration address: Česká republika, Praha, Velké Kunratické 1320/41, Kunratice, 14800 Praha 4
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 13 Aug 2015
Date of termination from office: 31 Jul 2017
Recorded in the Trade Register: 30 Dec 2016
Deleted from the Trade Register: 7 Nov 2017
Name: LADISLAV KRÁL
Registration address: Česká republika, Praha, Velké Kunratické 1426/28, Kunratice, 14800 Praha 4
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 13 Aug 2015
Recorded in the Trade Register: 13 Aug 2015
Deleted from the Trade Register: 30 Dec 2016
Name: FERID NASR
Registration address: Česká republika, Kořenov, č.p. 925, 46849 Kořenov
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 22 Jan 2013
Date of termination from office: 1 Sep 2020
Recorded in the Trade Register: 4 Feb 2013
Deleted from the Trade Register: 1 Sep 2020
Name: MARTINA SÍBRTOVÁ
Registration address: Česká republika, Tábor, Kvapilova 2970, 39003 Tábor
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Jan 2013
Recorded in the Trade Register: 4 Feb 2013
Deleted from the Trade Register: 18 Mar 2015
Name: ROMANA SLÍŽKOVÁ
Registration address: Česká republika, Libeř, č.p. 217, 25241 Libeř
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Jan 2013
Recorded in the Trade Register: 4 Feb 2013
Deleted from the Trade Register: 1 Sep 2020

Additional information regarding this governing body from the past

Provisions that previously applied to this governing body but are no longer valid

How members of this governing body could previously represent the legal entity:
  • Za společnost jednají vůči třetím stranám vždy dva členové představenstva společně. (from 13 Aug 2015 to 1 Sep 2020)
  • Za společnost jedná a právní úkony činí jménem společnosti předseda představenstva. Předseda představenstva se jménem společnosti podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. (from 20 Feb 2002 to 13 Aug 2015)

Abolished governing bodies and their representatives

Below you will find information about the abolished governing bodies of the legal entity DER Touristik CZ a.s. and their representatives. These are governing bodies that were previously established in the company but have now been dissolved and are no longer part of the management structure.

Managing board (Představenstvo), abolished

(Czech "Představenstvo") - is the governing body of a legal entity.
Existed from 20 Feb 2002 to 4 Feb 2013
Name: Ferid Nasr
Registration address: Česká republika, Kořenov, č.p. 925, 46849 Kořenov
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 3 Apr 2008
Date of termination from office: 31 Dec 2012
Recorded in the Trade Register: 6 Apr 2011
Deleted from the Trade Register: 4 Feb 2013
Name: Kristýna Nasrová-Pinarcioglu
Registration address: Česká republika, Praha, Milánská 462, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Dec 2010
Recorded in the Trade Register: 17 Feb 2011
Deleted from the Trade Register: 4 Feb 2013
Name: Ferid Nasr
Registration address: Česká republika, Praha, U zahrádek 139, Benice, 10300 Praha 10
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 3 Apr 2008
Recorded in the Trade Register: 16 Jun 2008
Deleted from the Trade Register: 6 Apr 2011
Name: Daniela Straková
Registration address: Česká republika, Liberec, Jeronýmova 476/23, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007 Liberec
Position in the governing body: místopředseda představenstva
Appointment date: 3 Apr 2008
Date of termination from office: 31 Dec 2012
Recorded in the Trade Register: 16 Jun 2008
Deleted from the Trade Register: 4 Feb 2013
Name: Šárka Nasrová
Registration address: Česká republika, Praha, U zahrádek 139, Benice, 10300 Praha 10
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 3 Apr 2008
Recorded in the Trade Register: 16 Jun 2008
Deleted from the Trade Register: 17 Feb 2011
Name: Ferid Nasr
Registration address: Česká republika, Praha, U zahrádek 139, Benice, 10300 Praha 10
Position in the governing body: předseda
Appointment date: 20 Feb 2002
Date of termination from office: 20 Feb 2007
Recorded in the Trade Register: 20 Feb 2002
Deleted from the Trade Register: 16 Jun 2008
Name: Lilia Lili
Registration address: Česká republika, Praha, Voskovcova 1075/49, Hlubočepy, 15200 Praha 5
Position in the governing body: místopředseda
Appointment date: 20 Feb 2002
Date of termination from office: 20 Feb 2007
Recorded in the Trade Register: 20 Feb 2002
Deleted from the Trade Register: 16 Jun 2008
Name: Šárka Nasrová
Registration address: Česká republika, Praha, U zahrádek 139, Benice, 10300 Praha 10
Position in the governing body: člen
Appointment date: 20 Feb 2002
Recorded in the Trade Register: 20 Feb 2002
Deleted from the Trade Register: 16 Jun 2008

Directors (Jednatel), abolished

Existed from 30 Apr 1992 to 20 Feb 2002
Name: Lilia Lili
Registration address: Česká republika, Praha, Jasenická 32/3, Sobín, 15521 Praha 5
Position in the governing body: jednatel
Recorded in the Trade Register: 30 Apr 1992
Deleted from the Trade Register: 30 Apr 1992
Name: Lucie Vojtelová
Registration address: Česká republika, Praha, Sokolovská 468/116, Karlín, 18600 Praha 8
Position in the governing body: jednatel
Recorded in the Trade Register: 30 Apr 1992
Deleted from the Trade Register: 26 Nov 1993
Name: Lilia Lili
Registration address: Česká republika, Praha, U smaltovny 1115/32, Holešovice, 17000 Praha 7
Position in the governing body: jednatel
Recorded in the Trade Register: 30 Apr 1992
Deleted from the Trade Register: 28 Jan 1998
Name: Ferid Nasr
Registration address: Česká republika, Praha, Sokolovská 468/116, Karlín, 18600 Praha 8
Position in the governing body: jednatel
Recorded in the Trade Register: 30 Apr 1992
Deleted from the Trade Register: 20 Feb 2002

Additional information regarding this governing body from the past years

Provisions that previously applied to this governing body but are no longer valid.

How members of this governing body could previously represent the legal entity:
  • Způsob jednání jménem společnosti: Jednatelé jsou oprávněni za společnost jednat v plném rozsahu samostatně. Podepisují se připojením celého jména s poznámkou "jednatel" k názvu společnosti. (from 30 Apr 1992 to 20 Feb 2002)

Members (owners), abolished

The legal entity DER Touristik CZ a.s. previously had a formal body of founders, which has now been abolished. This often occurs as a result of a change in the legal form of the entity. Below, you will find information about the founders who were registered in this previously existing body.

Former Members (owners)

Name: Ferid Nasr
Recorded in the Trade Register: 13 Aug 2001
Deleted from the Trade Register: 20 Feb 2002
Registration address: Česká republika, Praha, U zahrádek 139, Benice, 10300 Praha 10
Shares member previously held:
  • from 13 Aug 2001 to 20 Feb 2002: 50 000 Czech crowns , paid up to 100 percents , ownership stake (%) - 50%
Name: Lilia Lili
Recorded in the Trade Register: 13 Aug 2001
Deleted from the Trade Register: 20 Feb 2002
Registration address: Česká republika, Praha, Voskovcova 1075/49, Hlubočepy, 15200 Praha 5
Shares member previously held:
  • from 13 Aug 2001 to 20 Feb 2002: 50 000 Czech crowns , paid up to 100 percents , ownership stake (%) - 50%
Name: Lilia Lili
Recorded in the Trade Register: 3 Jan 2000
Deleted from the Trade Register: 13 Aug 2001
Registration address: Česká republika, Středokluky, Kladenská 1, 25268 Středokluky
Shares member previously held:
  • from 3 Jan 2000 to 13 Aug 2001: 100 000 Czech crowns , paid up to Splaceno
Name: Lilia Lili
Recorded in the Trade Register: 28 Jan 1998
Deleted from the Trade Register: 3 Jan 2000
Registration address: Česká republika, Praha, U smaltovny 1115/32, Holešovice, 17000 Praha 7
Shares member previously held:
  • from 28 Jan 1998 to 3 Jan 2000: 50 000 Czech crowns
Name: Ferid Nasr
Recorded in the Trade Register: 26 Nov 1993
Deleted from the Trade Register: 3 Jan 2000
Registration address: Česká republika, Praha, Sokolovská 468/116, Karlín, 18600 Praha 8
Shares member previously held:
  • from 26 Nov 1993 to 3 Jan 2000: 50 000 Czech crowns
Name: Lilia Lili
Recorded in the Trade Register: 26 Nov 1993
Deleted from the Trade Register: 28 Jan 1998
Registration address: Česká republika, Praha, U smaltovny 1115/32, Holešovice, 17000 Praha 7
Shares member previously held:
  • from 26 Nov 1993 to 28 Jan 1998: 50 000 Czech crowns
Name: Ferid Nasr
Recorded in the Trade Register: 30 Apr 1992
Deleted from the Trade Register: 26 Nov 1993
Registration address: Česká republika, Praha, Sokolovská 468/116, Karlín, 18600 Praha 8
Shares member previously held:
  • from 30 Apr 1992 to 26 Nov 1993: 0 Czech crowns
Name: Lucie Vojtelová
Recorded in the Trade Register: 30 Apr 1992
Deleted from the Trade Register: 26 Nov 1993
Registration address: Česká republika, Praha, Sokolovská 468/116, Karlín, 18600 Praha 8
Shares member previously held:
  • from 30 Apr 1992 to 26 Nov 1993: 0 Czech crowns
Name: Lilia Lili
Recorded in the Trade Register: 30 Apr 1992
Deleted from the Trade Register: 26 Nov 1993
Registration address: Česká republika, Praha, Jasenická 32/3, Sobín, 15521 Praha 5
Shares member previously held:
  • from 30 Apr 1992 to 26 Nov 1993: 0 Czech crowns

Shares of the legal entity (current, actual)

Information about currently issued shares, their quantity, and type (typically applicable to legal entities structured as joint-stock companies).
Currently active/issued shares:
  • from 5 Dec 2013 - Quantity: 100 issued shares , value per share 120 000 Czech crowns , Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights) , Form of shares: Physical shares (exist in physical form)

Share issuance history of the legal entity

Information about previously issued shares of the legal entity.
Share issuance history:
  • from 17 Feb 2011 to 5 Dec 2013 - Quantity: 100 issued shares , value per share 120 000 Czech crowns, Type of shares: Bearer shares (Czech: "Akcie na majitele", owned by whoever holds them, without specifying the person) , Form of shares: Physical shares (exist in physical form)
  • from 7 Oct 2005 to 17 Feb 2011 - Quantity: 100 issued shares , value per share 120 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights) , Form of shares: Physical shares (exist in physical form)
  • from 20 Feb 2002 to 7 Oct 2005 - Quantity: 12 issued shares , value per share 1 000 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights)

Supervisory Board (Dozorčí rada), current representatives

(Czech "Dozorčí rada") - is a supervisory board in many Czech legal entities.

Name: JAN ONDERČANIN
Registration address: Česká republika, Týnec nad Sázavou, Na Hlinkách 597, 25741 Týnec nad Sázavou
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 1 May 2024
Recorded in the Trade Register: 13 Jul 2024

Changes history of Supervisory Board representatives

Former representatives of the Supervisory Board (Dozorčí rada) and changes to their details

Name: PROKOP HAJNÝ
Registration address: Česká republika, Praha, Lékořicová 389/28, Křeslice, 10400 Praha 10
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 1 Sep 2020
Date of termination from position: 30 Apr 2024
Recorded in the Trade Register: 1 Sep 2020
Deleted from the Trade Register: 13 Jul 2024
Name: JOSEF SVOBODA
Registration address: Česká republika, Praha, U stanice 592/9, Liboc, 16100 Praha 6
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 1 Jan 2013
Date of termination from position: 1 Sep 2020
Recorded in the Trade Register: 4 Feb 2013
Deleted from the Trade Register: 1 Sep 2020
Name: DANIELA STRAKOVÁ
Registration address: Česká republika, Liberec, Jeronýmova 476/23, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007 Liberec
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 1 Jan 2013
Date of termination from position: 13 Aug 2015
Recorded in the Trade Register: 4 Feb 2013
Deleted from the Trade Register: 13 Aug 2015
Name: Martina Síbrtová
Registration address: Česká republika, Tábor, Kvapilova 2970, 39003 Tábor
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 1 Dec 2010
Recorded in the Trade Register: 17 Feb 2011
Deleted from the Trade Register: 4 Feb 2013
Name: Josef Svoboda
Registration address: Česká republika, Praha, U stanice 592/9, Liboc, 16100 Praha 6
Position: předseda
Appointment date: 28 Sep 2008
Date of termination from position: 31 Dec 2012
Recorded in the Trade Register: 23 Oct 2008
Deleted from the Trade Register: 4 Feb 2013
Name: Romana Slížková
Registration address: Česká republika, Praha, Cílkova 649/4, Kamýk, 14200 Praha 4
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 22 Sep 2008
Recorded in the Trade Register: 23 Oct 2008
Deleted from the Trade Register: 4 Feb 2013
Name: Ferdinand Macharáček
Registration address: Česká republika, Praha, Šalounova 1933/18, Chodov, 14900 Praha 4
Position: člen
Appointment date: 28 Aug 2008
Recorded in the Trade Register: 23 Oct 2008
Deleted from the Trade Register: 17 Feb 2011
Name: Ferdinad Macharáček
Registration address: Česká republika, Praha, Šalounova 1933/18, Chodov, 14900 Praha 4
Position: člen
Appointment date: 21 Feb 2003
Recorded in the Trade Register: 26 Jun 2003
Deleted from the Trade Register: 23 Oct 2008
Name: Josef Svoboda
Registration address: Česká republika, Praha, U stanice 592/9, Liboc, 16100 Praha 6
Position: předseda
Appointment date: 21 Feb 2003
Date of termination from position: 21 Feb 2008
Recorded in the Trade Register: 26 Jun 2003
Deleted from the Trade Register: 23 Oct 2008
Name: Nataša Volfová
Registration address: Česká republika, Tábor, Kpt. Jaroše 2387, 39003 Tábor
Position: člen
Appointment date: 21 Feb 2003
Recorded in the Trade Register: 26 Jun 2003
Deleted from the Trade Register: 23 Oct 2008
Name: Nataša Volfová
Registration address: Česká republika, Tábor, Kpt. Jaroše 2387, 39003 Tábor
Position: člen
Appointment date: 20 Feb 2002
Recorded in the Trade Register: 20 Feb 2002
Deleted from the Trade Register: 26 Jun 2003
Name: Josef Svoboda
Registration address: Česká republika, Praha, U stanice 592/9, Liboc, 16100 Praha 6
Position: předseda
Appointment date: 20 Feb 2002
Recorded in the Trade Register: 20 Feb 2002
Deleted from the Trade Register: 26 Jun 2003
Name: Ferdinad Macharáček
Registration address: Česká republika, Praha, Šalounova 1933/18, Chodov, 14900 Praha 4
Position: člen
Appointment date: 20 Feb 2002
Recorded in the Trade Register: 20 Feb 2002
Deleted from the Trade Register: 26 Jun 2003

Shareholders (Akcionář),current, actual

Unfortunately, it is not always possible to identify the shareholders of a Czech legal entity. Information about them is often hidden in the company's internal records.

Shareholders, current

Individuals currently holding shares in the legal entity.

Name: DER Touristik Eastern Europe a.s.
Verify data
Registration number (IČO): 24159921
Registration address: Česká republika, Praha, Babákova 2390/2, Chodov, 14800 Praha 4
Recorded in the Trade Register: 3 Sep 2020

Shareholder history

Former shareholders of the legal entity. This information is not always available, as the legislation of the Czech Republic allows the legal entities to hide this information in the internal documents (for example for joint-stock companies). Nevertheless, we will still try to identify them.

Name: EXIM HOLDING a.s.
Verify data
Registration number (IČO): 24159921
Registration address: Česká republika, Praha, Babákova 2390/2, Chodov, 14800 Praha 4
Recorded in the Trade Register: 28 Oct 2017
Deleted from the Trade Register: 3 Sep 2020
Name: EXIM HOLDING a.s.
Verify data
Registration number (IČO): 24159921
Registration address: Česká republika, Praha, Revoluční 1044/23, Staré Město, 11000 Praha 1
Recorded in the Trade Register: 16 Nov 2016
Deleted from the Trade Register: 28 Oct 2017
Name: EXIM HOLDING a.s.
Verify data
Registration number (IČO): 24159921
Registration address: Česká republika, Praha, Revoluční 1044/23, Staré Město, 11000 Praha 1
Recorded in the Trade Register: 31 Jan 2012
Deleted from the Trade Register: 16 Nov 2016

Business activities/licences of company DER Touristik CZ a.s.

In this section, you will find information about all types of activities/licences of the legal entity DER Touristik CZ a.s., both currently active and previously registered. Please note that in the Czech Republic, business activities are initially recorded in the company's Articles of Association (usually in general terms) but must also be registered with the Trade Licensing Office (živnostenský úřad in Czech), where more specific, individual licenses of the legal entity are recorded. Below, we provide data from both sources. Unfortunately, the information is currently available only in the Czech language. For translation, please use your browser's built-in translation tool..

Actual business activites by the of Articles of Association

These are the types of business activities originally defined in the company's Articles of Association, actual to this moment.

  • Provozování cestovní kanceláře pořádání zájezdů (from 25 Jul 2025)
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech činnosti: - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Ubytovací služby, - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - Činnost informačních a zpravodajských kanceláří, - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - Pronájem a půjčování věcí movitých, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - Překladatelská a tlumočnická činnost, - Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. (from 25 Jul 2025)
  • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (from 25 Jul 2025)
  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (from 25 Jul 2025)

History of changes business activites by Articles of Association

Types of activities previously listed in the Articles of Association of the company DER Touristik CZ a.s., but no longer active (removed from the Articles of Association):

  • poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (from 4 Jun 2012 to 25 Jul 2025)
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (from 27 Jan 2011 to 25 Jul 2025)
  • vydavatelské a nakladatelské činnosti (from 19 Sep 2002 to 27 Jan 2011)
  • reklamní činnost a marketing (from 13 Aug 2001 to 27 Jan 2011)
  • provozování cestovní kanceláře (from 22 Nov 1993 to 25 Jul 2025)
  • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu (from 30 Apr 1992 to 27 Jan 2011)
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (from 30 Apr 1992 to 27 Jan 2011)

Current business activities/licences of per Trade Licensing Office

Current types of activities of the company DER Touristik CZ a.s. as issued by the Trade Licensing Office of the Czech Republic ("živnostenský úřad" in Czech).

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (from 30 Apr 1992)
    • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce (from 3 Nov 2008)
    • Zprostředkování obchodu a služeb (from 3 Nov 2008)
    • Velkoobchod a maloobchod (from 3 Nov 2008)
    • Ubytovací služby (from 3 Nov 2008)
    • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály (from 3 Nov 2008)
    • Pronájem a půjčování věcí movitých (from 3 Nov 2008)
    • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (from 3 Nov 2008)
    • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení (from 3 Nov 2008)
    • Překladatelská a tlumočnická činnost (from 3 Nov 2008)
    • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu (from 3 Nov 2008)
    • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí (from 13 Aug 2013)
    • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří (from 13 Aug 2013)
    • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí (from 3 Mar 2020)
  • Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů (from 31 May 1995)
  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (from 13 Jan 2023)

History of business activities of per Trade Licensing Office

Previously registered business activities of DER Touristik CZ a.s. issued by Trade Licensing Office (živnostenský úřad), which are no longer valid.

  • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (from 12 Dec 2011 to 1 Mar 2017)
  • Reklamní činnost a marketing (from 1 Aug 2001 to 30 Jun 2008)
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (from 30 Apr 1992 to 30 Jun 2008)
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu (from 30 Apr 1992 to 30 Jun 2008)
  • Vydavatelské a nakladatelské činnosti (from 17 Jun 2002 to 30 Jun 2008)

Additional Information about the legal entity

Any other data that has been entered into the company's charter or recorded in the Trade Register. Unfortunately, this information is currently available only in the Czech language. For translation, please use your browser's built-in translation tool.

Currently registered records

Records that are valid at the present time:

  • Na obchodní společnost DER Touristik CZ a.s., IČ 45312974, se sídlem Babákova 2390/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, jako společnost nástupnickou, přešlo na základě fúze sloučením jmění obchodní společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., IČ 26141647, se sídlem Babákova 2390/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, a obchodní společnosti CKF facility s.r.o., IČ 28982738, se sídlem Na Strži 65/1702 140 62 Praha 4 - Nusle, jako společností zanikajících. (date of record 2 Jan 2023)
  • Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. (date of record 13 Aug 2015)
  • Společnost změnila právní formu ze společnosti EXIM TOURS spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Revoluční 23, PSČ 110 00, IČ 45 3 1 29 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 9241. (date of record 20 Feb 2002)

Historical additional information about the legal entity

Any other data of the legal entity that was previously recorded in the company’s charter or the Trade Register but is no longer valid.

  • Na obchodní společnost DER Touristik CZ a.s., IČ 45312974, se sídlem Babákova 2390/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, jako společnost nástupnickou, přešlo na základě fúze sloučením jmění obchodní společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., IČ 26141647, se sídlem Babákova 2390/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, a obchodní společnosti CKF facility s.r.o., IČ 28982738, se sídlem Na Strži 65/1702 140 62 Praha 4 - Nusle, jako společností zanikajících. (from 1 Jan 2023 to 2 Jan 2023)
  • Obchodní společnost EXIM TOURS spol.s r.o. , se sídlem Praha 1, Revoluční 23, IČ 45 31 29 74 byla zapsána v oddíle C, vložce 9241 a z důvodu změny právní formy byl její zápis převeden do oddílu B, vložky 7557. (from 20 Feb 2002 to 20 Feb 2002)
  • Datum uzavření společenské smlouvy: 28.1.1992 (from 30 Apr 1992 to 20 Feb 2002)