Extract for the legal entity Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. (IČO: 25820826)
Basic information
Tax identification number (Tax ID, "DIČ" in Czech): CZ25820826
Date of establishment/registration: 15 Sep 1998
Governing bodies and their representatives (current, active)
In the sections below, you will find information about the currently active governing bodies of the legal entity Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. and the appointed representatives in each body.
Directors (Jednatel), current representatives
Registration address: Česká republika, Dolní Kralovice, Vraždovy Lhotice 61, 25768 Dolní Kralovice
Position in the governing body: jednatel
Appointment date: 1 Apr 2021
Recorded in the Trade Register: 6 Aug 2023
Registration address: Česká republika, Libeř, č.p. 265, 25241 Libeř
Position in the governing body: jednatel
Appointment date: 1 Apr 2021
Recorded in the Trade Register: 1 Apr 2021
Registration address: Česká republika, Brno, Útěchovská 730/2b, Soběšice, 64400 Brno
Position in the governing body: jednatel
Appointment date: 1 Apr 2021
Recorded in the Trade Register: 1 Apr 2021
Authority to represent the legal entity
- Každý jednatel je oprávněn zastupovat společnost samostatně. (from 1 Apr 2021)
Directors (Jednatel), history of changes
Below, you will find the representatives of Directors (Jednatel), who were previously appointed, as well as changes to their details.
Registration address: Česká republika, Dolní Kralovice, Smetanova 170, 25768 Dolní Kralovice
Position in the governing body: jednatel
Appointment date: 1 Apr 2021
Recorded in the Trade Register: 1 Apr 2021
Deleted from the Trade Register: 6 Aug 2023
Abolished governing bodies and their representatives
Below you will find information about the abolished governing bodies of the legal entity Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. and their representatives. These are governing bodies that were previously established in the company but have now been dissolved and are no longer part of the management structure.
Managing board (Představenstvo), abolished
(Czech "Představenstvo") - is the governing body of a legal entity.Registration address: Česká republika, Dolní Kralovice, Smetanova 170, 25768 Dolní Kralovice
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 15 Nov 2018
Recorded in the Trade Register: 10 Feb 2021
Deleted from the Trade Register: 1 Apr 2021
Registration address: Česká republika, Praha, Postlova 698, Hostavice, 19800 Praha 9
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Oct 2020
Recorded in the Trade Register: 5 Dec 2020
Deleted from the Trade Register: 1 Apr 2021
Registration address: Česká republika, Praha, Vidoulská 773/18, Jinonice, 15800 Praha 5
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 31 Dec 2019
Recorded in the Trade Register: 14 Jan 2020
Deleted from the Trade Register: 1 Apr 2021
Registration address: Česká republika, Libeř, č.p. 265, 25241 Libeř
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 6 Jan 2020
Date of termination from office: 1 Apr 2021
Recorded in the Trade Register: 14 Jan 2020
Deleted from the Trade Register: 1 Apr 2021
Registration address: Česká republika, Libeř, č.p. 265, 25241 Libeř
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 30 May 2019
Recorded in the Trade Register: 30 May 2019
Deleted from the Trade Register: 14 Jan 2020
Registration address: Česká republika, Brno, Podpěrova 433/3, Medlánky, 62100 Brno
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 3 May 2019
Recorded in the Trade Register: 21 May 2019
Deleted from the Trade Register: 5 Dec 2020
Registration address: Česká republika, Dolní Kralovice, Vraždovy Lhotice 17, 25768 Dolní Kralovice
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 15 Nov 2018
Recorded in the Trade Register: 28 Nov 2018
Deleted from the Trade Register: 10 Feb 2021
Registration address: Česká republika, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Boženy Němcové 766/4, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 15 Nov 2018
Recorded in the Trade Register: 28 Nov 2018
Deleted from the Trade Register: 1 Apr 2021
Registration address: Česká republika, Brno, Kytnerova 534/17, Medlánky, 62100 Brno
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 18 Apr 2018
Recorded in the Trade Register: 25 Apr 2018
Deleted from the Trade Register: 1 Apr 2021
Registration address: Česká republika, Všechovice, č.p. 193, 75353 Všechovice
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 2 Jul 2017
Date of termination from office: 31 Dec 2019
Recorded in the Trade Register: 17 Jul 2017
Deleted from the Trade Register: 14 Jan 2020
Registration address: Česká republika, Všechovice, č.p. 193, 75353 Všechovice
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 1 Jul 2012
Date of termination from office: 1 Jul 2017
Recorded in the Trade Register: 9 Mar 2017
Deleted from the Trade Register: 17 Jul 2017
Registration address: Česká republika, Jesenice, V Podlesí 114, Zdiměřice, 25242 Jesenice
Position in the governing body: Místopředseda představenstva
Appointment date: 19 Oct 2015
Date of termination from office: 1 Apr 2021
Recorded in the Trade Register: 13 Nov 2015
Deleted from the Trade Register: 1 Apr 2021
Registration address: Česká republika, Brno, Mojžíšova 2901/17, Královo Pole, 61200 Brno
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 19 Aug 2015
Recorded in the Trade Register: 28 Aug 2015
Deleted from the Trade Register: 21 May 2019
Registration address: Česká republika, Všechovice, č.p. 173, 75353 Všechovice
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 1 Jul 2012
Recorded in the Trade Register: 13 May 2015
Deleted from the Trade Register: 9 Mar 2017
Registration address: Česká republika, Jesenice, V Podlesí 114, Zdiměřice, 25242 Jesenice
Position in the governing body: místopředseda představenstva
Appointment date: 15 Jun 2011
Date of termination from office: 19 Aug 2015
Recorded in the Trade Register: 13 May 2015
Deleted from the Trade Register: 28 Aug 2015
Registration address: Česká republika, Dolní Kralovice, Vraždovy Lhotice 17, 25768 Dolní Kralovice
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 15 Nov 2013
Recorded in the Trade Register: 26 Jul 2014
Deleted from the Trade Register: 28 Nov 2018
Registration address: Česká republika, Libeř, č.p. 265, 25241 Libeř
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 30 May 2014
Recorded in the Trade Register: 24 Jun 2014
Deleted from the Trade Register: 30 May 2019
Registration address: Česká republika, Lučina, č.p. 284, 73939 Lučina
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 15 Nov 2013
Recorded in the Trade Register: 5 Feb 2014
Deleted from the Trade Register: 26 Jul 2014
Registration address: Česká republika, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Boženy Němcové 766/4, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 15 Nov 2013
Recorded in the Trade Register: 5 Feb 2014
Deleted from the Trade Register: 28 Nov 2018
Registration address: Česká republika, Všechovice, č.p. 173, 75353 Všechovice
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 1 Jul 2012
Recorded in the Trade Register: 27 Aug 2012
Deleted from the Trade Register: 13 May 2015
Registration address: Česká republika, Modlany, č.p. 124, 41713 Modlany
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 15 Jun 2011
Date of termination from office: 1 Jul 2012
Recorded in the Trade Register: 27 Aug 2012
Deleted from the Trade Register: 27 Aug 2012
Registration address: Česká republika, Jesenice, V Podlesí 114, Zdiměřice, 25242 Jesenice
Position in the governing body: místopředseda představenstva
Appointment date: 15 Jun 2011
Recorded in the Trade Register: 27 Aug 2012
Deleted from the Trade Register: 13 May 2015
Registration address: Česká republika, Libeř, č.p. 265, 25241 Libeř
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 29 May 2009
Recorded in the Trade Register: 1 Jul 2009
Deleted from the Trade Register: 24 Jun 2014
Registration address: Česká republika, Jesenice, V Podlesí 114, Zdiměřice, 25242 Jesenice
Position in the governing body: místopředseda představenstva
Appointment date: 3 Dec 2007
Date of termination from office: 15 Jun 2011
Recorded in the Trade Register: 9 Jan 2008
Deleted from the Trade Register: 27 Aug 2012
Registration address: Česká republika, Brandýs nad Labem, Boženy Němcové 766/4, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Česká republika
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 3 Dec 2007
Recorded in the Trade Register: 9 Jan 2008
Deleted from the Trade Register: 5 Feb 2014
Registration address: Česká republika, Lučina, č.p. 284, 73939 Lučina
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 3 Dec 2007
Recorded in the Trade Register: 9 Jan 2008
Deleted from the Trade Register: 5 Feb 2014
Registration address: Česká republika, Modlany, č.p. 124, 41713 Modlany
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 3 Dec 2007
Date of termination from office: 15 Jun 2011
Recorded in the Trade Register: 9 Jan 2008
Deleted from the Trade Register: 27 Aug 2012
Registration address: Česká republika, Jesenice, V Podlesí 114, Zdiměřice, 25242 Jesenice
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 27 Oct 2006
Recorded in the Trade Register: 14 Dec 2006
Deleted from the Trade Register: 9 Jan 2008
Registration address: Česká republika, Modlany, č.p. 124, 41713 Modlany
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 19 Jun 2006
Recorded in the Trade Register: 14 Jul 2006
Deleted from the Trade Register: 9 Jan 2008
Registration address: Česká republika, Praha, Slezská 2148/109, Vinohrady, 13000 Praha 3
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 31 Dec 2005
Date of termination from office: 19 Jun 2006
Recorded in the Trade Register: 1 Feb 2006
Deleted from the Trade Register: 14 Jul 2006
Registration address: Česká republika, Rosice, Dobrovského 196, 66501 Rosice
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 11 Apr 2005
Recorded in the Trade Register: 24 Sep 2005
Deleted from the Trade Register: 29 Aug 2008
Registration address: Česká republika, Ostrava, Krestova 1289/11, Hrabůvka, 70030 Ostrava
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 11 Apr 2005
Recorded in the Trade Register: 24 Sep 2005
Deleted from the Trade Register: 14 Jul 2006
Registration address: Česká republika, Ostrava, Mlynářská 708/7, Hrabová, 72000 Ostrava
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 8 Apr 2003
Date of termination from office: 31 Dec 2005
Recorded in the Trade Register: 22 Jul 2003
Deleted from the Trade Register: 1 Feb 2006
Registration address: Česká republika, Brno, Rolnická 660/5, Bohunice, 62500 Brno
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 8 Apr 2003
Recorded in the Trade Register: 22 Jul 2003
Deleted from the Trade Register: 24 Sep 2005
Registration address: Česká republika, Praha, U Pentlovky 464/13, Troja, 18100 Praha 8
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 8 Apr 2003
Recorded in the Trade Register: 22 Jul 2003
Deleted from the Trade Register: 24 Sep 2005
Registration address: Česká republika, Ostrava, Červenkova 1980/2, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 12 Mar 2002
Date of termination from office: 8 Apr 2003
Recorded in the Trade Register: 11 Dec 2002
Deleted from the Trade Register: 22 Jul 2003
Registration address: Česká republika, Kopřivnice, Družební 1004/4, 74221 Kopřivnice
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 12 Mar 2002
Date of termination from office: 8 Apr 2003
Recorded in the Trade Register: 11 Dec 2002
Deleted from the Trade Register: 22 Jul 2003
Registration address: Česká republika, Ostrava, Paskovská 935/298, Hrabová, 72000 Ostrava
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 12 Mar 2002
Date of termination from office: 8 Apr 2003
Recorded in the Trade Register: 11 Dec 2002
Deleted from the Trade Register: 22 Jul 2003
Registration address: Česká republika, Ostrava, Kpt. Vajdy 3202/6, Zábřeh, 70030 Ostrava
Position in the governing body: předseda představenstva
Date of termination from office: 12 Mar 2002
Recorded in the Trade Register: 15 Sep 1998
Deleted from the Trade Register: 11 Dec 2002
Registration address: Česká republika, Ostrava, Červenkova 1980/2, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava
Position in the governing body: člen představenstva
Date of termination from office: 12 Mar 2002
Recorded in the Trade Register: 15 Sep 1998
Deleted from the Trade Register: 11 Dec 2002
Registration address: Česká republika, Příbor, Štefánikova 694, 74258 Příbor
Position in the governing body: člen představenstva
Date of termination from office: 12 Mar 2002
Recorded in the Trade Register: 15 Sep 1998
Deleted from the Trade Register: 11 Dec 2002
Additional information regarding this governing body from the past years
Provisions that previously applied to this governing body but are no longer valid.
- Členové představenstva zastupují a podepisují jménem Společnosti následovně: a) předseda představenstva zastupuje a podepisuje jménem Společnosti samostatně, b) další členové představenstva zastupují a podepisují jménem Společnosti společně s předsedou či místopředsedou představenstva. (from 13 Nov 2015 to 1 Apr 2021)
- Členové představenstva jsou oprávněni jednat a podepisovat jménem společnosti následovně: a) předseda představenstva jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně, b) další členové představenstva jednají a podepisují jménem společnosti společně s předsedou či místopředsedou představenstva. (from 9 Jan 2008 to 13 Nov 2015)
- J e d n á n í : Jednat jménem společnosti a podepisovat za společnost jsou oprávněni všichni členové představenstva, a to každý samostatně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. (from 15 Sep 1998 to 9 Jan 2008)
Members (owners)
A formal Body of Members, meaning individuals or legal entities, who actually own shares in the company.Members (owners), current
Verify data
Registration number (IČO): 00176150
Recorded in the Trade Register: 1 Apr 2021
Registration address: Česká republika, Brno, Žarošická 4395/13, Židenice, 62800 Brno
Share in the registered capital:
- from 1 Apr 2021: 5 800 000 Czech crowns , paid up to 100 percents , ownership stake (%) - 100
No changes in Members (owners) occurred
No changes in owners in the legal entity Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. or their details have occurred. This situation is fully possible.Share issuance history of the legal entity
Information about previously issued shares of the legal entity.Share issuance history:
- from 30 Aug 2016 to 1 Apr 2021 - Quantity: 580 issued shares , value per share 10 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights) , Form of shares: Book-entry shares (recorded in the company’s register, no separate paper form)
- from 9 Jan 2008 to 30 Aug 2016 - Quantity: 580 issued shares , value per share 10 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights) , Form of shares: Physical shares (exist in physical form)
- from 15 Mar 2006 to 15 Mar 2006 - Quantity: 500 issued shares , value per share 10 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights) , Form of shares: Physical shares (exist in physical form)
- from 15 Mar 2006 to 9 Jan 2008 - Quantity: 500 issued shares , value per share 10 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights) , Form of shares: Physical shares (exist in physical form)
- from 16 Feb 2006 to 15 Mar 2006 - Quantity: 500 issued shares , value per share 10 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights)
- from 11 Dec 2002 to 16 Feb 2006 - Quantity: 500 issued shares , value per share 10 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights)
- from 15 Sep 1998 to 11 Dec 2002 - Quantity: 100 issued shares , value per share 10 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights)
Supervisory Board (Dozorčí rada), current representatives
(Czech "Dozorčí rada") - is a supervisory board in many Czech legal entities.
No current representatives found
This means that this type of corporate body is established in the legal entity, but currently has no appointed active representatives, which is a possible situation. You can view previous representatives by clicking the button to show the full history of changes.
Changes history of Supervisory Board representatives
Former representatives of the Supervisory Board (Dozorčí rada) and changes to their details
Registration address: Česká republika, Brno, Říčanská 1000/29, Žebětín, 64100 Brno
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 20 Sep 2016
Recorded in the Trade Register: 30 Sep 2016
Deleted from the Trade Register: 1 Apr 2021
Registration address: Česká republika, Brno, Tomečkova 887/3, Lesná, 63800 Brno
Position: Předseda dozorčí rady
Appointment date: 31 Aug 2015
Date of termination from position: 1 Apr 2021
Recorded in the Trade Register: 7 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 1 Apr 2021
Registration address: Česká republika, Brno, Sýpka 1353/29, Černá Pole, 61300 Brno
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 31 Aug 2015
Recorded in the Trade Register: 7 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 30 Sep 2016
Registration address: Česká republika, Brno, Útěchovská 730/2b, Soběšice, 64400 Brno
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 31 Aug 2015
Recorded in the Trade Register: 7 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 1 Apr 2021
Registration address: Česká republika, Bílovice nad Svitavou, Obřanská 897, 66401 Bílovice nad Svitavou
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 11 Nov 2013
Recorded in the Trade Register: 5 Feb 2014
Deleted from the Trade Register: 28 Aug 2015
Registration address: Česká republika, Brno, Demlova 276/24, Černá Pole, 61300 Brno
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 11 Nov 2013
Recorded in the Trade Register: 5 Feb 2014
Deleted from the Trade Register: 28 Aug 2015
Registration address: Česká republika, Brno, Tichého 561/18, Žabovřesky, 61600 Brno
Position: předseda dozorčí rady
Appointment date: 15 Nov 2013
Date of termination from position: 20 Aug 2015
Recorded in the Trade Register: 5 Feb 2014
Deleted from the Trade Register: 28 Aug 2015
Registration address: Česká republika, Brno, Tichého 561/18, Žabovřesky, 61600 Brno
Position: předseda dozorčí rady
Appointment date: 15 Sep 2011
Date of termination from position: 11 Nov 2013
Recorded in the Trade Register: 27 Aug 2012
Deleted from the Trade Register: 5 Feb 2014
Registration address: Česká republika, Brno, Tichého 561/18, Žabovřesky, 61600 Brno
Position: předseda dozorčí rady
Appointment date: 25 May 2009
Date of termination from position: 15 Sep 2011
Recorded in the Trade Register: 1 Jul 2009
Deleted from the Trade Register: 27 Aug 2012
Registration address: Česká republika, Brno, Hilleho 1838/1, Černá Pole, 60200 Brno
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 4 Feb 2008
Recorded in the Trade Register: 29 Aug 2008
Deleted from the Trade Register: 5 Feb 2014
Registration address: Česká republika, Brno, Demlova 276/24, Černá Pole, 61300 Brno
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 4 Feb 2008
Recorded in the Trade Register: 29 Aug 2008
Deleted from the Trade Register: 5 Feb 2014
Registration address: Česká republika, Brno, Tichého 561/18, Žabovřesky, 61600 Brno
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 19 Sep 2006
Recorded in the Trade Register: 14 Dec 2006
Deleted from the Trade Register: 1 Jul 2009
Registration address: Česká republika, Kokory, č.p. 278, 75105 Kokory
Position: předseda dozorčí rady
Appointment date: 20 Sep 2006
Date of termination from position: 4 Feb 2008
Recorded in the Trade Register: 14 Dec 2006
Deleted from the Trade Register: 29 Aug 2008
Registration address: Česká republika, Ostrava, Hlučínská 17/254, Petřkovice, 72529 Ostrava
Position: předseda
Appointment date: 8 Apr 2003
Date of termination from position: 20 Jul 2006
Recorded in the Trade Register: 22 Jul 2003
Deleted from the Trade Register: 14 Dec 2006
Registration address: Česká republika, Brno, Tichého 561/18, Žabovřesky, 61600 Brno
Position: člen
Appointment date: 8 Apr 2003
Recorded in the Trade Register: 22 Jul 2003
Deleted from the Trade Register: 29 Aug 2008
Registration address: Česká republika, Široká Niva, 79322 Široká Niva 5, Česká republika
Position: člen
Appointment date: 12 Mar 2002
Date of termination from position: 8 Apr 2003
Recorded in the Trade Register: 11 Dec 2002
Deleted from the Trade Register: 22 Jul 2003
Registration address: Česká republika, Krnov, Bezručova 2314/29, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov
Position: předseda
Appointment date: 12 Mar 2002
Date of termination from position: 8 Apr 2003
Recorded in the Trade Register: 11 Dec 2002
Deleted from the Trade Register: 22 Jul 2003
Registration address: Česká republika, Kokory, č.p. 450, 75105 Kokory
Position: člen
Appointment date: 12 Mar 2002
Recorded in the Trade Register: 11 Dec 2002
Deleted from the Trade Register: 14 Dec 2006
Registration address: Česká republika, Krnov, Bezručova 2314/29, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov
Position: člen
Appointment date: 1 Oct 2001
Date of termination from position: 12 Mar 2002
Recorded in the Trade Register: 4 Sep 2002
Deleted from the Trade Register: 11 Dec 2002
Registration address: Česká republika, Ostrava-Přívoz, Hlučínská 26/148, Ostrava-Přívoz, Česká republika
Position: člen
Recorded in the Trade Register: 13 Dec 1999
Deleted from the Trade Register: 4 Sep 2002
Registration address: Česká republika, Ostrava, Staňkova 232/16, Výškovice, 70030 Ostrava
Position: předseda
Date of termination from position: 12 Mar 2002
Recorded in the Trade Register: 13 Dec 1999
Deleted from the Trade Register: 11 Dec 2002
Registration address: Česká republika, Ostrava, Vítkovická 3252, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Position: člen
Date of termination from position: 12 Mar 2002
Recorded in the Trade Register: 15 Sep 1998
Deleted from the Trade Register: 11 Dec 2002
Registration address: Česká republika, Bohumín, Myslivecká 809, Skřečoň, 73531 Bohumín
Position: předseda
Recorded in the Trade Register: 15 Sep 1998
Deleted from the Trade Register: 13 Dec 1999
Registration address: Česká republika, Kopřivnice, Tyršova 504/5, 74221 Kopřivnice
Position: člen
Recorded in the Trade Register: 15 Sep 1998
Deleted from the Trade Register: 13 Dec 1999
Shareholders (Akcionář),current, actual
Unfortunately, it is not always possible to identify the shareholders of a Czech legal entity. Information about them is often hidden in the company's internal records.
Shareholders, current
Individuals currently holding shares in the legal entity.
No current representatives found
This means that this type of corporate body is established in the legal entity, but currently has no appointed active representatives, which is a possible situation. You can view previous representatives by clicking the button to show the full history of changes.
Shareholder history
Former shareholders of the legal entity. This information is not always available, as the legislation of the Czech Republic allows the legal entities to hide this information in the internal documents (for example for joint-stock companies). Nevertheless, we will still try to identify them.
Verify data
Registration number (IČO): 00176150
Registration address: Česká republika, Brno, Žarošická 4395/13, Židenice, 62800 Brno
Recorded in the Trade Register: 28 Aug 2015
Deleted from the Trade Register: 1 Apr 2021
Business activities/licences of company Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.
In this section, you will find information about all types of activities/licences of the legal entity Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., both currently active and previously registered. Please note that in the Czech Republic, business activities are initially recorded in the company's Articles of Association (usually in general terms) but must also be registered with the Trade Licensing Office (živnostenský úřad in Czech), where more specific, individual licenses of the legal entity are recorded. Below, we provide data from both sources. Unfortunately, the information is currently available only in the Czech language. For translation, please use your browser's built-in translation tool..
Actual business activites by the of Articles of Association
These are the types of business activities originally defined in the company's Articles of Association, actual to this moment.
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (from 13 Nov 2015)
History of changes business activites by Articles of Association
Types of activities previously listed in the Articles of Association of the company Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., but no longer active (removed from the Articles of Association):
- zprostředkování obchodu a služeb (from 29 Aug 2008 to 13 Nov 2015)
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců (from 29 Aug 2008 to 13 Nov 2015)
- zpracování dat, služby databank, správa sítí (from 29 Aug 2008 to 13 Nov 2015)
- poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) (from 13 Dec 1999 to 13 Nov 2015)
- poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky, software a informačních systémů (from 13 Dec 1999 to 13 Nov 2015)
- projektování elektrických zařízení (from 13 Dec 1999 to 6 Mar 2006)
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů (from 13 Dec 1999 to 6 Mar 2006)
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení (from 13 Dec 1999 to 6 Mar 2006)
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (from 15 Sep 1998 to 13 Nov 2015)
Current business activities/licences of per Trade Licensing Office
Current types of activities of the company Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. as issued by the Trade Licensing Office of the Czech Republic ("živnostenský úřad" in Czech).
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (from 15 Sep 1998)
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály (from 10 Dec 2002)
- Velkoobchod a maloobchod (from 1 Sep 2004)
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (from 28 May 2008)
- Zprostředkování obchodu a služeb (from 28 May 2008)
- Pronájem a půjčování věcí movitých (from 9 Oct 2024)
History of business activities of per Trade Licensing Office
Previously registered business activities of Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. issued by Trade Licensing Office (živnostenský úřad), which are no longer valid.
- Zprostředkování obchodu a služeb (from 28 May 2008 to 30 Jun 2008)
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců (from 28 May 2008 to 30 Jun 2008)
- Zpracování dat, služby databank, správa sítí (from 28 May 2008 to 30 Jun 2008)
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (from 15 Sep 1998 to 30 Jun 2008)
- Poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky, software a informačních systémů (from 28 Jul 1999 to 30 Jun 2008)
- Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení (from 8 Sep 1999 to 25 Jan 2006)
- Projektování elektrických zařízení (from 8 Sep 1999 to 23 Aug 2000)
- Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů (from 8 Sep 1999 to 25 Jan 2006)
- Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) (from 21 Oct 1998 to 30 Jun 2008)
- Projektování elektrických zařízení (from 8 Sep 1999 to 25 Jan 2006)
Additional Information about the legal entity
Any other data that has been entered into the company's charter or recorded in the Trade Register. Unfortunately, this information is currently available only in the Czech language. For translation, please use your browser's built-in translation tool.
Currently registered records
Records that are valid at the present time:
- Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 29.03.2021 došlo ke změně právní formy společnosti z dosavadní právní formy "akciová společnost" na právní formu "společnost s ručením omezeným", a to na základě Projektu změny právní formy ze dne 03.02.2021. (date of record 1 Apr 2021)
- Na základě projektu vnitrostátní fúze ze dne 17.5.2016 došlo k fúzi sloučením společností WEBCOM Technology Innovation s.r.o., se sídlem Praha 10 - Michle, U Plynárny 1002/97, PSČ 10100, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159810, IČ 286 04 121 a WEBCOM SERVICES s.r.o., se sídlem Praha 10 - Michle, U Plynárny 1002/97, PSČ 10100, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159573 , IČ 286 04 113, jakožto zanikajících společností a společnosti WEBCOM a.s., se sídlem U plynárny 1002/97, Michle, 101 00 Praha 10, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16870, IČ 258 20 826, jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost WEBCOM a.s., přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnosti WEBCOM Technology Innovation s.r.o. a WEBCOM SERVICES s.r.o., které zanikly v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, se vymazávají z obchodního rejstříku. (date of record 30 Jun 2016)
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. (date of record 13 May 2015)
- Dne 5.10.2009 rozhodla valná hromada společnosti WEBCOM AXPERIENCE a.s. o rozdělení společnosti WEBCOM AXPERIENCE a.s. ve formě rozdělení odštěpením se vznikem dvou nových nástupnických společností s ručením omezeným. Část jmění rozdělované společnosti specifiková v Projektu rozdělení přechází v důsledku rozdělení do nově vzniklé nástupnické společnosti WEBCOM SERVICES s.r.o., a část jmění rozdělované společnosti specifikovaná v Projektu rozdělení přechází v důsledku rozdělení do nově vzniklé nástupnické společnosti WEBCOM SUPPORT s.r.o. (date of record 29 Oct 2009)
- Na společnost WEBCOM a.s., sídlem Ostrava, Kunčičky, 624/11, PSČ 71800, IČ: 258 20 826, přešla na základě smlouvy o rozdělení odštěpením a převzetí části obchodního jmění ze dne 3.12.2007 odštěpovaná část obchodního jmění společnosti AXPERIENCE a.s., IČ: 272 00 191, se sídlem Praha 10, Michle, U Plynárny 1002/97, PSČ 101 00, a to v rozsahu dle uvedené smlouvy o rozdělení odštěpením a převzetí části obchodního jmění ze dne 3.12.2007. (date of record 9 Jan 2008)
Historical additional information about the legal entity
Any other data of the legal entity that was previously recorded in the company’s charter or the Trade Register but is no longer valid.
- Počet členů statutárního orgánu: 5 (from 5 Feb 2014 to 28 Aug 2015)
- Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: (from 24 Apr 2002 to 1 Apr 2021)
- mimořádná valná hromada akciové společnosti WEBCOM a.s., se sídlem Ostrava, Masná 4, PSČ 702 00, IČ 25 82 08 26, rozhodla o schválení usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: (from 24 Apr 2002 to 1 Apr 2021)
- a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o 4.000.000,-Kč, slovy: čtyřimilionykorunčeských, upisování akcií nad částku 4.000.000,-Kč se nepřipouští, (from 24 Apr 2002 to 1 Apr 2021)
- b) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to upsáním 400, slovy: čtyřista, kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč, slovy: desettisíckorunčeských, všechny akcie jsou kmenové, na jméno, v zaknihované podobě, (from 24 Apr 2002 to 1 Apr 2021)
- c) veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tedy 400, slovy: čtyřista, kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-Kč, slovy: desettisíckorunčeských, všechny akcie jsou kmenové, na jméno, v zaknihované podobě, budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, za těchto podmínek: (from 24 Apr 2002 to 1 Apr 2021)
- dohoda akcionářů bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů, přičemž tato lhůta začne běžet patnáctým dnem ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu, kterým bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, (from 24 Apr 2002 to 1 Apr 2021)
- skutečnost, že usnesení rejstříkového soudu nabylo právní moci, sdělí představenstvo akcionářům společnosti písemným oznámením, osobně doručeným akcionářům do vlastních rukou, nejpozději do deseti dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu, kterým bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, (from 24 Apr 2002 to 1 Apr 2021)
- emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé akcie je 10 000,-Kč, slovy: desettisíckorunčeských, emisní kurs akcií bude splacen peněžitými vklady, (from 24 Apr 2002 to 1 Apr 2021)
- akcionáři jsou povinni do 30 dnů ode dne uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, a to na účet společnosti WEBCOM a.s., vedený u IC Banky, a.s., číslo účtu 0040007258/6100. (from 24 Apr 2002 to 1 Apr 2021)