Extract for the legal entity ENERGY Ústí nad Labem, a.s. (IČO: 25540971)

Date and time of the extract: 14 Dec 2025, 22:31 (Prague time)*
NEW SEARCH

Basic information

Company name: ENERGY Ústí nad Labem, a.s. (from 13 Dec 2005)
- Previous name - CINERGETIKA Ú/L, a.s. (from 28 Jul 1999 to 13 Dec 2005)
- Previous name - SETUZA energetika, a.s. (from 5 Oct 1998 to 28 Jul 1999)
Registration number (IČO): 25540971
Tax identification number (Tax ID, "DIČ" in Czech): CZ25540971
Date of establishment/registration: 5 Oct 1998
- Registration number (IČO), tax ID (DIČ) and registration date are permanent data of the Czech legal entity and do not change
Legal address: Česká republika, Ústí nad Labem, Žukovova 100/27, Střekov, 40003 Ústí nad Labem (from 20 Oct 2015)
- Previously - Česká republika, Ústí nad Labem, Žukovova 100/27, Střekov, 40003 Ústí nad Labem (from 16 Oct 1998 to 20 Oct 2015)
- Previously - Česká republika, Brno, Šumavská 416/15, Ponava, 60200 Brno (from 5 Oct 1998 to 16 Oct 1998)
Share capital: 501 215 000 Czech crowns , paid on 100 percents (from 19 Jan 2005)
- Previously - 701 000 000 Czech crowns , paid on 100 percents (from 5 Oct 1998 to 19 Jan 2005)
Legal form: Joint-stock company, stock corporation ("a.s.") (from 5 Oct 1998)
- The legal form capital has not changed
Company status (Good standing): Legal entity is active
- Tracking changes to the company's status is very hard – please refer to the notes on company name changes for clarity.
Registering authority: Court KSUL, section B, archive number 1172 (from 9 Dec 1998)
- Previously - Court KSBR, section B, archive number 2772 (from 5 Oct 1998 to 9 Dec 1998) ;

Governing bodies and their representatives (current, active)

In the sections below, you will find information about the currently active governing bodies of the legal entity ENERGY Ústí nad Labem, a.s. and the appointed representatives in each body.

Administrative Board (Správní rada), current representatives

(Czech "Správní rada") - is a legal entity’s body combining both managerial and supervisory functions.

Number of members in this governing body currently defined by the charter: 1 (from 25 Feb 2021)
Name: MILOŠ HRUBÝ
Registration address: Česká republika, Praha, Václavské náměstí 821/39, Nové Město, 11000 Praha 1
Position in the governing body: člen správní rady
Appointment date: 24 Sep 2020
Recorded in the Trade Register: 24 Sep 2020

Authority to represent the legal entity

How members of this governing body can currently represent the legal entity:
  • Společnost zastupuje člen správní rady samostatně. (from 25 Feb 2021)
In this governing body of the legal entity ENERGY Ústí nad Labem, a.s., there have been no changes to representatives or their details

Abolished governing bodies and their representatives

Below you will find information about the abolished governing bodies of the legal entity ENERGY Ústí nad Labem, a.s. and their representatives. These are governing bodies that were previously established in the company but have now been dissolved and are no longer part of the management structure.

Director (Statutární ředitel), abolished

A governing body of a Czech legal entity with the authority to represent the legal entity in all matters and in full capacity.

Existed from 24 Sep 2020 to 1 Jan 2021
Former number of members in the body: 1 (from 24 Sep 2020 to 1 Jan 2021)
Name: MILOŠ HRUBÝ
Registration address: Česká republika, Praha, Václavské náměstí 821/39, Nové Město, 11000 Praha 1
Position in the governing body: statutární ředitel
Appointment date: 24 Sep 2020
Recorded in the Trade Register: 24 Sep 2020
Deleted from the Trade Register: 1 Jan 2021

Additional information regarding this governing body from the past years

Provisions that previously applied to this governing body but are no longer valid.

How members of this governing body could previously represent the legal entity:
  • Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. (from 24 Sep 2020 to 1 Jan 2021)

Managing board (Představenstvo), abolished

(Czech "Představenstvo") - is the governing body of a legal entity.
Existed from 5 Oct 1998 to 24 Sep 2020
Former number of members in the body: 1 (from 28 Aug 2019 to 24 Sep 2020)
Former number of members in the body: 2 (from 5 Apr 2018 to 28 Aug 2019)
Former number of members in the body: 3 (from 20 Oct 2015 to 5 Apr 2018)
Name: MILOŠ HRUBÝ
Registration address: Česká republika, Praha, Václavské náměstí 821/39, Nové Město, 11000 Praha 1
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 5 Oct 2015
Recorded in the Trade Register: 28 Aug 2019
Deleted from the Trade Register: 24 Sep 2020
Name: JAN VOJTĚCH
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Jizerská 2907/12, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 5 Oct 2015
Recorded in the Trade Register: 26 Apr 2019
Deleted from the Trade Register: 3 May 2019
Name: MILOŠ HRUBÝ
Registration address: Česká republika, Praha, Václavské náměstí 821/39, Nové Město, 11000 Praha 1
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 28 Feb 2019
Date of termination from office: 28 Aug 2019
Recorded in the Trade Register: 26 Apr 2019
Deleted from the Trade Register: 28 Aug 2019
Name: MILOŠ HRUBÝ
Registration address: Česká republika, Praha, Václavské náměstí 821/39, Nové Město, 11000 Praha 1
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 5 Oct 2015
Recorded in the Trade Register: 20 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 26 Apr 2019
Name: JAN VOJTĚCH
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Jizerská 2907/12, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 5 Oct 2015
Date of termination from office: 28 Feb 2019
Recorded in the Trade Register: 20 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 26 Apr 2019
Name: MILOŠ HRUBÝ
Registration address: Česká republika, Praha, Václavské náměstí 821/39, Nové Město, 11000 Praha 1
Position in the governing body: Člen představenstva
Appointment date: 1 Feb 2006
Date of termination from office: 5 Oct 2015
Recorded in the Trade Register: 20 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 20 Oct 2015
Name: JAN VOJTĚCH
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Jizerská 2907/12, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem
Position in the governing body: Předseda představenstva
Appointment date: 1 Feb 2006
Date of termination from office: 5 Oct 2015
Recorded in the Trade Register: 20 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 20 Oct 2015
Name: JAN VOJTĚCH
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Jizerská 2907/12, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem
Position in the governing body: Předseda představenstva
Appointment date: 1 Feb 2006
Recorded in the Trade Register: 3 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 20 Oct 2015
Name: MILOŠ HRUBÝ
Registration address: Česká republika, Praha, Václavské náměstí 821/39, Nové Město, 11000 Praha 1
Position in the governing body: Člen představenstva
Appointment date: 1 Feb 2006
Recorded in the Trade Register: 5 Aug 2015
Deleted from the Trade Register: 20 Oct 2015
Name: Miloš Hrubý
Registration address: Česká republika, Praha 1, Václavské náměstí 821/37, 11000 Praha 1 - Nové Město, Česká republika
Position in the governing body: Člen představenstva
Appointment date: 1 Feb 2006
Recorded in the Trade Register: 11 Apr 2006
Deleted from the Trade Register: 5 Aug 2015
Name: Jan Vojtěch
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Jizerská 2907/12, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem
Position in the governing body: Předseda představenstva
Appointment date: 1 Feb 2006
Recorded in the Trade Register: 11 Apr 2006
Deleted from the Trade Register: 3 Oct 2015
Name: Petr Hartman
Registration address: Česká republika, Praha, Mezilesí 2060/4, Horní Počernice, 19300 Praha 9
Position in the governing body: Místopředseda představenstva
Appointment date: 18 Apr 2005
Date of termination from office: 30 Jun 2005
Recorded in the Trade Register: 7 Oct 2005
Deleted from the Trade Register: 10 Oct 2005
Name: Peter Kušnír
Registration address: Slovensko, Bratislava, Furdekova 2, 85103 Bratislava, Slovensko
Position in the governing body: Místopředseda představenstva
Appointment date: 17 Feb 2005
Date of termination from office: 18 Apr 2005
Recorded in the Trade Register: 1 Jun 2005
Deleted from the Trade Register: 7 Oct 2005
Name: Erik Čebík
Registration address: Slovensko, Liptovský Hrádok, Překážka 726/25, 03301 Liptovský Hrádok, Slovensko
Position in the governing body: Předseda představenstva
Appointment date: 17 Feb 2005
Date of termination from office: 25 Jan 2006
Recorded in the Trade Register: 1 Jun 2005
Deleted from the Trade Register: 11 Apr 2006
Name: Jan Vojtěch
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Jizerská 2907/12, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem
Position in the governing body: Člen představenstva
Appointment date: 11 Apr 2003
Recorded in the Trade Register: 21 Oct 2003
Deleted from the Trade Register: 11 Apr 2006
Name: Jaroslav Kulhánek
Registration address: Česká republika, Vizovice, Masarykovo nám. 1129, 76312 Vizovice
Position in the governing body: Místopředseda představenstva
Appointment date: 20 Dec 2002
Date of termination from office: 17 Feb 2005
Recorded in the Trade Register: 30 Jul 2003
Deleted from the Trade Register: 1 Jun 2005
Name: Josef Gába
Registration address: Česká republika, Racková, č.p. 97, 76001 Racková
Position in the governing body: Předseda představenstva
Appointment date: 23 Jul 2002
Date of termination from office: 17 Feb 2005
Recorded in the Trade Register: 23 Oct 2002
Deleted from the Trade Register: 1 Jun 2005
Name: Jan Vaněček
Registration address: Česká republika, Praha, U kříže 631/18, Jinonice, 15800 Praha 5
Position in the governing body: Člen představenstva
Appointment date: 19 Apr 2001
Recorded in the Trade Register: 4 Aug 2001
Deleted from the Trade Register: 21 Oct 2003
Name: Ladislav Těťál
Registration address: Česká republika, Plzeň, Karolíny Světlé 15, 32318 Plzeň, okres: Chomutov, Česká republika
Position in the governing body: Předseda představenstva
Appointment date: 20 Apr 2001
Date of termination from office: 16 Jul 2002
Recorded in the Trade Register: 4 Aug 2001
Deleted from the Trade Register: 23 Oct 2002
Name: Petr Šulc
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Nová 1399/22, Střekov, 40003 Ústí nad Labem
Position in the governing body: Místopředseda představenstva
Appointment date: 20 Apr 2001
Date of termination from office: 17 Dec 2002
Recorded in the Trade Register: 4 Aug 2001
Deleted from the Trade Register: 30 Jul 2003
Name: Ladislav Těťál
Registration address: Česká republika, Plzeň, Karoliny Světlé 467/15, Severní Předměstí, 32300 Plzeň
Position in the governing body: Místopředseda představenstva
Recorded in the Trade Register: 2 Nov 2000
Deleted from the Trade Register: 4 Aug 2001
Name: Luděk Horn
Registration address: Česká republika, Plzeň, Zbrojnická 229/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
Position in the governing body: Člen představenstva
Recorded in the Trade Register: 1 Sep 2000
Deleted from the Trade Register: 2 Nov 2000
Name: Petr Moravec
Registration address: Česká republika, Nymburk, Kounice 255, Nymburk, Česká republika
Position in the governing body: Člen představenstva
Recorded in the Trade Register: 1 Sep 2000
Deleted from the Trade Register: 2 Nov 2000
Name: Vladimír Prerad
Registration address: Česká republika, Praha, Týnská 624/13, Staré Město, 11000 Praha 1
Position in the governing body: Předseda představenstva
Date of termination from office: 19 Apr 2001
Recorded in the Trade Register: 26 May 1999
Deleted from the Trade Register: 4 Aug 2001
Name: Ladislav Ťeťál
Registration address: Česká republika, Plzeň, Prešovská 199/10, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
Position in the governing body: Člen představenstva
Recorded in the Trade Register: 26 May 1999
Deleted from the Trade Register: 2 Nov 2000
Name: Stanislav Komín
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Kollárova 1080/5, Střekov, 40003 Ústí nad Labem
Position in the governing body: předseda představenstva
Recorded in the Trade Register: 5 Oct 1998
Deleted from the Trade Register: 26 May 1999
Name: Petr Šulc
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Nová 1399/22, Střekov, 40003 Ústí nad Labem
Position in the governing body: člen představenstva
Recorded in the Trade Register: 5 Oct 1998
Deleted from the Trade Register: 4 Aug 2001
Name: Petr Jirout
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Žukovova 719/12, Střekov, 40003 Ústí nad Labem
Position in the governing body: člen představenstva
Recorded in the Trade Register: 5 Oct 1998
Deleted from the Trade Register: 26 May 1999

Additional information regarding this governing body from the past years

Provisions that previously applied to this governing body but are no longer valid.

How members of this governing body could previously represent the legal entity:
  • Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. (from 28 Aug 2019 to 24 Sep 2020)
  • Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. (from 20 Oct 2015 to 28 Aug 2019)
  • Za společnost jedná a podepisuje jeho předseda samostatně nebo místopředseda samostatně. Podepisování za společnost se děje takovým způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. (from 1 Sep 2000 to 20 Oct 2015)
  • Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva společně alespoň s jedním členem představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. (from 5 Oct 1998 to 1 Sep 2000)

Shares of the legal entity (current, actual)

Information about currently issued shares, their quantity, and type (typically applicable to legal entities structured as joint-stock companies).
Currently active/issued shares:
  • from 24 Sep 2020 - Quantity: 5 issued shares , value per share 100 243 000 Czech crowns , Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights) , Form of shares: Physical shares (exist in physical form)

Share issuance history of the legal entity

Information about previously issued shares of the legal entity.
Share issuance history:
  • from 24 Sep 2020 to 24 Sep 2020 - Quantity: 1 issued shares , value per share 501 215 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights) , Form of shares: Physical shares (exist in physical form)
  • from 20 Oct 2015 to 24 Sep 2020 - Quantity: 701 issued shares , value per share 715 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights) , Form of shares: Physical shares (exist in physical form)
  • from 19 Jan 2005 to 20 Oct 2015 - Quantity: 701 issued shares , value per share 715 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person)
  • from 28 Jul 1999 to 19 Jan 2005 - Quantity: 701 issued shares , value per share 1 000 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person)
  • from 5 Oct 1998 to 28 Jul 1999 - Quantity: 701 issued shares , value per share 1 000 000 Czech crowns, Type of shares: Bearer shares (Czech: "Akcie na majitele", owned by whoever holds them, without specifying the person)

Supervisory Board (Dozorčí rada), abolished

This legal entity previously had a Supervisory Board (Dozorčí rada), which has now been abolished or modified. However, you can still view information about the former representatives of the Supervisory Board who were appointed in the past.

Existed from 5 Oct 1998 to 24 Sep 2020
Name: ADÉLA JUNGROVÁ
Registration address: Česká republika, Jesenice, Platanová 835, 25242 Jesenice
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 3 May 2017
Recorded in the Trade Register: 28 Aug 2019
Deleted from the Trade Register: 24 Sep 2020
Name: JINDŘICH KAUCA
Registration address: Česká republika, Proboštov, Přítkov 101, 41712 Proboštov
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 20 Dec 2016
Recorded in the Trade Register: 30 Nov 2018
Deleted from the Trade Register: 26 Apr 2019
Name: ADÉLA JUNGROVÁ
Registration address: Česká republika, Jesenice, Platanová 835, 25242 Jesenice
Position: předseda dozorčí rady
Appointment date: 10 May 2017
Date of termination from position: 28 Aug 2019
Recorded in the Trade Register: 14 Sep 2017
Deleted from the Trade Register: 28 Aug 2019
Name: ADÉLA JUNGROVÁ
Registration address: Česká republika, Jesenice, Platanová 835, 25242 Jesenice
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 3 May 2017
Recorded in the Trade Register: 27 May 2017
Deleted from the Trade Register: 14 Sep 2017
Name: JINDŘICH KAUCA
Registration address: Česká republika, Proboštov, Na Výsluní 84, Přítkov, 41712 Proboštov
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 20 Dec 2016
Recorded in the Trade Register: 27 May 2017
Deleted from the Trade Register: 30 Nov 2018
Name: JOSEF DRAČÍNSKÝ
Registration address: Česká republika, Sezemice, Smetanova 435, 53304 Sezemice
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 16 Nov 2001
Date of termination from position: 5 Oct 2015
Recorded in the Trade Register: 20 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 20 Oct 2015
Name: ŠTEFAN LONCNAR
Registration address: Česká republika, Praha, Klausova 2541/15, Stodůlky, 15500 Praha 5
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 1 Feb 2006
Date of termination from position: 5 Oct 2015
Recorded in the Trade Register: 20 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 20 Oct 2015
Name: XENIE KUBÍKOVÁ
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Masarykova 2293/148b, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 5 Oct 2015
Date of termination from position: 28 Aug 2019
Recorded in the Trade Register: 20 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 28 Aug 2019
Name: ALEŠ VOLF
Registration address: Česká republika, Praha, Nerudova 208/8, Malá Strana, 11800 Praha 1
Position: Předseda dozorčí rady
Appointment date: 1 Feb 2006
Date of termination from position: 5 Oct 2015
Recorded in the Trade Register: 20 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 20 Oct 2015
Name: KAREL KOHLIK
Registration address: Itálie, Campione d'Italia, via Totone 29, 22060 Campione d'Italia, Itálie
Position: předseda dozorčí rady
Appointment date: 5 Oct 2015
Date of termination from position: 3 May 2017
Recorded in the Trade Register: 20 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 27 May 2017
Name: ALEŠ VOLF
Registration address: Česká republika, Praha, Nerudova 208/8, Malá Strana, 11800 Praha 1
Position: Předseda dozorčí rady
Appointment date: 1 Feb 2006
Recorded in the Trade Register: 18 Sep 2013
Deleted from the Trade Register: 20 Oct 2015
Name: Štefan Loncnar
Registration address: Česká republika, Praha, Klausova 2541/15, Stodůlky, 15500 Praha 5
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 1 Feb 2006
Recorded in the Trade Register: 11 Apr 2006
Deleted from the Trade Register: 20 Oct 2015
Name: Aleš Volf
Registration address: Česká republika, Praha, Blatenská 2180/5, Chodov, 14800 Praha 4
Position: Předseda dozorčí rady
Appointment date: 1 Feb 2006
Recorded in the Trade Register: 11 Apr 2006
Deleted from the Trade Register: 18 Sep 2013
Name: Viktor Levkanič
Registration address: Slovensko, Bratislava, Arménská 13827/10, 82107 Bratislava - Vrakuňa, Slovensko
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 17 Feb 2005
Recorded in the Trade Register: 1 Jun 2005
Deleted from the Trade Register: 11 Apr 2006
Name: Martin Kvietik
Registration address: Slovensko, Bratislava, Holubyho 1, 81103 Bratislava, Slovensko
Position: Předseda dozorčí rady
Appointment date: 23 Feb 2005
Date of termination from position: 25 Jan 2006
Recorded in the Trade Register: 1 Jun 2005
Deleted from the Trade Register: 11 Apr 2006
Name: Jaroslav Bobák
Registration address: Česká republika, Zlín, Jílová 4578, 76005 Zlín
Position: Předseda dozorčí rady
Appointment date: 15 Apr 2003
Date of termination from position: 17 Feb 2005
Recorded in the Trade Register: 21 Oct 2003
Deleted from the Trade Register: 1 Jun 2005
Name: František Šanda
Registration address: Česká republika, Podhradní Lhota, č.p. 109, 76871 Podhradní Lhota
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 18 Dec 2002
Recorded in the Trade Register: 30 Jul 2003
Deleted from the Trade Register: 1 Jun 2005
Name: Josef Dračínský
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Tolstého 1301/29, Střekov, 40003 Ústí nad Labem
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 16 Nov 2001
Recorded in the Trade Register: 25 Jan 2002
Deleted from the Trade Register: 20 Oct 2015
Name: Aleš Chytrý
Registration address: Česká republika, Seč, č.p. 4, 33601 Seč
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 19 Apr 2001
Recorded in the Trade Register: 4 Aug 2001
Deleted from the Trade Register: 30 Jul 2003
Name: Luděk Horn
Registration address: Česká republika, Plzeň, Zbrojnická 229/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 19 Apr 2001
Recorded in the Trade Register: 4 Aug 2001
Deleted from the Trade Register: 25 Jan 2002
Name: Jan Vojtěch
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Jizerská 2907/12, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem
Position: Předseda dozorčí rady
Appointment date: 20 Apr 2001
Date of termination from position: 10 Apr 2003
Recorded in the Trade Register: 4 Aug 2001
Deleted from the Trade Register: 21 Oct 2003
Name: Jiří Radoch
Registration address: Česká republika, Litvínov, Čapkova 2033, Horní Litvínov, 43601 Litvínov
Position: Člen dozorčí rady
Recorded in the Trade Register: 26 May 1999
Deleted from the Trade Register: 4 Aug 2001
Name: Lenka Dernerová
Registration address: Česká republika, Most, J.Skupy 202/2305, 43401 Most, Česká republika
Position: Člen dozorčí rady
Recorded in the Trade Register: 26 May 1999
Deleted from the Trade Register: 4 Aug 2001
Name: Jana Klíčková
Registration address: Česká republika, Karlovy Vary, Moskevská 1668/104, 36001 Karlovy Vary
Position: Člen dozorčí rady
Recorded in the Trade Register: 26 May 1999
Deleted from the Trade Register: 4 Aug 2001
Name: Miloslav Baloun
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Masarykova 141/379, Bukov, 40001 Ústí nad Labem
Position: člen dozorčí rady
Recorded in the Trade Register: 5 Oct 1998
Deleted from the Trade Register: 26 May 1999
Name: Jan Vojtěch
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Jizerská 2907/12, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem
Position: člen dozorčí rady
Recorded in the Trade Register: 5 Oct 1998
Deleted from the Trade Register: 26 May 1999
Name: Václav Petržíla
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Koněvova 3202/38, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem
Position: předseda dozorčí rady
Recorded in the Trade Register: 5 Oct 1998
Deleted from the Trade Register: 26 May 1999

Shareholders (Akcionář),current, actual

Unfortunately, it is not always possible to identify the shareholders of a Czech legal entity. Information about them is often hidden in the company's internal records.

Shareholders, current

Individuals currently holding shares in the legal entity.

Name: Elrond Holding CZ a.s.
Verify data
Registration number (IČO): 27391051
Registration address: Česká republika, Praha, Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 11000 Praha 1
Recorded in the Trade Register: 22 Sep 2022

Shareholder history

Former shareholders of the legal entity. This information is not always available, as the legislation of the Czech Republic allows the legal entities to hide this information in the internal documents (for example for joint-stock companies). Nevertheless, we will still try to identify them.

Name: Elrond Holding CZ a.s.
Verify data
Registration number (IČO): 27391051
Registration address: Česká republika, Praha, Pařížská 68/9, Josefov, 11000 Praha 1
Recorded in the Trade Register: 5 Nov 2015
Deleted from the Trade Register: 22 Sep 2022
Name: PONCE a.s.
Verify data
Registration number (IČO): 27391051
Registration address: Česká republika, Praha, Diamantová 736/27, Slivenec, 15400 Praha 5
Recorded in the Trade Register: 14 Oct 2015
Deleted from the Trade Register: 5 Nov 2015
Name: PONCE a.s.
Verify data
Registration number (IČO): 27391051
Registration address: Česká republika, Praha, Ovocný trh 572/11, Staré Město, 11000 Praha 1
Recorded in the Trade Register: 11 Apr 2006
Deleted from the Trade Register: 14 Oct 2015
Name: SLAVIA CAPITAL Energy, a.s.
Registration address: Slovensko, Bratislava, Heydukova 6, 81108 Bratislava, Slovensko
Recorded in the Trade Register: 1 Jun 2005
Deleted from the Trade Register: 11 Apr 2006
Name: SETUZA, a.s.
Verify data
Registration number (IČO): 46708707
Registration address: Česká republika, Ústí nad Labem, Žukovova 100/27, Střekov, 40003 Ústí nad Labem
Recorded in the Trade Register: 5 Oct 1998
Deleted from the Trade Register: 26 May 1999

Business activities/licences of company ENERGY Ústí nad Labem, a.s.

In this section, you will find information about all types of activities/licences of the legal entity ENERGY Ústí nad Labem, a.s., both currently active and previously registered. Please note that in the Czech Republic, business activities are initially recorded in the company's Articles of Association (usually in general terms) but must also be registered with the Trade Licensing Office (živnostenský úřad in Czech), where more specific, individual licenses of the legal entity are recorded. Below, we provide data from both sources. Unfortunately, the information is currently available only in the Czech language. For translation, please use your browser's built-in translation tool..

Actual business activites by the of Articles of Association

These are the types of business activities originally defined in the company's Articles of Association, actual to this moment.

  • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (from 20 Oct 2015)
  • obchod s plynem (from 20 Oct 2015)
  • obchod s elektřinou (from 20 Oct 2015)
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (from 20 Oct 2015)
  • rozvod tepelné energie (from 22 May 2002)
  • výroba tepelné energie (from 22 May 2002)
  • distribuce plynu (from 22 May 2002)
  • distribuce elektřiny (from 22 May 2002)
  • výroba elektřiny (from 22 May 2002)

History of changes business activites by Articles of Association

Types of activities previously listed in the Articles of Association of the company ENERGY Ústí nad Labem, a.s., but no longer active (removed from the Articles of Association):

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (from 20 Oct 2015 to 20 Oct 2015)
  • pronájem a půjčování věcí movitých (from 22 May 2002 to 20 Oct 2015)
  • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) (from 22 May 2002 to 20 Oct 2015)
  • zprostředkování služeb (from 22 May 2002 to 20 Oct 2015)
  • zprostředkování obchodu (from 22 May 2002 to 20 Oct 2015)
  • specializovaný maloobchod (from 22 May 2002 to 20 Oct 2015)
  • maloobchod se smíšeným zbožím (from 22 May 2002 to 20 Oct 2015)
  • velkoobchod (from 22 May 2002 to 20 Oct 2015)
  • rozvod plynu (from 6 Nov 2001 to 22 May 2002)
  • pronájem nebytových prostor vázáno na poskytování vedlejších služeb (from 19 Mar 1999 to 22 May 2002)
  • podnikání v oblasti nakládání s odpady v režimu živností volných (neopravňuje k nakládání s nebezpečnými odpady) (from 19 Mar 1999 to 22 May 2002)
  • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (from 19 Mar 1999 to 22 May 2002)
  • výroba elektřiny (from 19 Mar 1999 to 22 May 2002)
  • rozvod elektřiny (from 19 Mar 1999 to 22 May 2002)
  • výroba tepla (from 19 Mar 1999 to 22 May 2002)
  • rozvod tepla (from 19 Mar 1999 to 22 May 2002)
  • leasing (from 16 Oct 1998 to 22 May 2002)
  • zprostředkovatelská činnost (from 5 Oct 1998 to 22 May 2002)
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (from 5 Oct 1998 to 22 May 2002)

Current business activities/licences of per Trade Licensing Office

Current types of activities of the company ENERGY Ústí nad Labem, a.s. as issued by the Trade Licensing Office of the Czech Republic ("živnostenský úřad" in Czech).

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (from 5 Oct 1998)
    • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody (from 15 Jun 2022)
    • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) (from 15 Jun 2022)
    • Zprostředkování obchodu a služeb (from 15 Jun 2022)
    • Velkoobchod a maloobchod (from 15 Jun 2022)
    • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy (from 15 Jun 2022)
    • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí (from 15 Jun 2022)
    • Pronájem a půjčování věcí movitých (from 15 Jun 2022)

History of business activities of per Trade Licensing Office

Previously registered business activities of ENERGY Ústí nad Labem, a.s. issued by Trade Licensing Office (živnostenský úřad), which are no longer valid.

  • Maloobchod se smíšeným zbožím (from 5 Oct 1998 to 30 Jun 2008)
  • Zprostředkování služeb (from 5 Oct 1998 to 30 Jun 2008)
  • Zprostředkovatelská činnost (from 5 Oct 1998 to 27 Feb 2002)
  • Pronájem a půjčování věcí movitých (from 8 Oct 1998 to 30 Jun 2008)
  • Velkoobchod (from 5 Oct 1998 to 30 Jun 2008)
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (from 5 Oct 1998 to 27 Feb 2002)
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) (from 14 Dec 1998 to 30 Jun 2008)
  • Specializovaný maloobchod (from 5 Oct 1998 to 30 Jun 2008)
  • Zprostředkování obchodu (from 5 Oct 1998 to 30 Jun 2008)
  • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (from 19 Jan 1999 to 14 Jun 2004)
  • Pronájem nebytových prostor vázáno na poskytování vedlejších služeb (from 14 Dec 1998 to 27 Feb 2002)

Additional Information about the legal entity

Any other data that has been entered into the company's charter or recorded in the Trade Register. Unfortunately, this information is currently available only in the Czech language. For translation, please use your browser's built-in translation tool.

Currently registered records

Records that are valid at the present time:

  • Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. (date of record 20 Oct 2015)
  • Oddíl B vložka 2772 se u z a v í r á . Společnost SETUZA energetika,a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Žukovova 100, PSČ 400 03 bude nadále vedena v oddílu B vložka 1172 Krajského soudu v Ústí nad Labem. (date of record 18 Jan 1999)
  • S účinností od 9.12.1998 se z a p i s u j e obchodní společnost SETUZA energetika, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Žukovova 100, PSČ 400 03 do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu B, vložka 1175. (date of record 9 Dec 1998)

Historical additional information about the legal entity

Any other data of the legal entity that was previously recorded in the company’s charter or the Trade Register but is no longer valid.

  • Řádná valná hromada společnosti přijala dne 25. června 2004 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Snížení základního kapitálu společnosti je dobrovolné a jeho důvodem jsou strukturální změny v rámci skupiny společností, jejíž součástí je společnost. 2. Základní kapitál společnosti se snižuje ze 701.000.000 Kč na 501.215.000 Kč, tedy o částku 199.785.000 Kč. 3. Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie nebo zatímní listy. Snížení základního kapitálu bude tedy provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti. Společnost vydala 701 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kčkaždá. Jmenovitá hodnota všech akcií bude snížena o částku 285.000 Kč, tedy na jmenovitou hodnotu 715.000 Kč každá. 4. Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti bude provedeno výměnou akcií za akcie o nové jmenovité hodnotě. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady k výměně akcií. Lhůta pro předložení akcií za účelem jejichvýměny činí 30 dnů od právní moci usnesení soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vrácené akcie budou společnosti poté zničeny. 5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude poměrně vyplacena akcionářům společnosti. K výplatě dojde do 30 dnů po právní moci usnesení soudu o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. (from 5 Aug 2004 to 19 Jan 2005)
  • Omezení převoditelnosti akcií na jméno : Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady podle § 25 stanov společnosti. Převod se uskutečňuje na základě písemné smlouvy rubopisem a předáním akcie. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje zápis o převodu do seznamu akcionářů. Převodce akcie (dřívější akcionář) nebo nabyvatel akcie (nový akcionář) je povinen doručit kopii smlouvy o převodu nebo jiného potvrzení o uskutečnění převodu akcie představenstvu společnosti do 3 dnů od tohoto převodu. (from 28 Jul 1999 to 22 May 2002)