Extract for the legal entity CE Power Industries a.s. (IČO: 06710930)

Date and time of the extract: 14 Dec 2025, 14:29 (Prague time)*
NEW SEARCH

Basic information

Company name: CE Power Industries a.s. (from 27 Jan 2020)
- Previous name - CE Industries a.s. (from 19 Aug 2019 to 27 Jan 2020)
- Previous name - SPV VTK a.s. (from 26 Feb 2018 to 19 Aug 2019)
- Previous name - CSG SPV a.s. (from 22 Dec 2017 to 26 Feb 2018)
Registration number (IČO): 06710930
Tax identification number (Tax ID, "DIČ" in Czech): CZ06710930
Date of establishment/registration: 22 Dec 2017
- Registration number (IČO), tax ID (DIČ) and registration date are permanent data of the Czech legal entity and do not change
Legal address: Česká republika, Ostrava, Vrázova 1321/23, Vítkovice, 70300 Ostrava (from 21 Dec 2020)
- Previously - Česká republika, Ostrava, Ruská 2929/101a, Vítkovice, 70300 Ostrava (from 19 Aug 2019 to 21 Dec 2020)
- Previously - Česká republika, Praha, Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 11000 Praha 1 (from 22 Dec 2017 to 19 Aug 2019)
Share capital: 2 105 263 Czech crowns , paid on 100 percents (from 29 Mar 2023)
- Previously - 2 000 000 Czech crowns , paid on 100 percents (from 22 Dec 2017 to 29 Mar 2023)
Legal form: Joint-stock company, stock corporation ("a.s.") (from 22 Dec 2017)
- The legal form capital has not changed
Company status (Good standing): Legal entity is active
- Tracking changes to the company's status is very hard – please refer to the notes on company name changes for clarity.
Registering authority: Court KSOS, section B, archive number 11146 (from 24 Sep 2019)
- Previously - Court MSPH, section B, archive number 23101 (from 22 Dec 2017 to 24 Sep 2019) ;

Governing bodies and their representatives (current, active)

In the sections below, you will find information about the currently active governing bodies of the legal entity CE Power Industries a.s. and the appointed representatives in each body.

Managing board (Představenstvo), current representatives

Number of members in this governing body currently defined by the charter: 5 (from 16 Nov 2022)
- Previously - number of members: 3 (from 19 Aug 2019 to 16 Nov 2022)
Name: JIŘÍ RABIEC
Registration address: Česká republika, Ludgeřovice, Na Mokřinách 1622/6a, 74714 Ludgeřovice
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Jun 2023
Recorded in the Trade Register: 8 Dec 2023
Name: PETER SZUMA
Registration address: Česká republika, Tlustice, č.p. 310, 26801 Tlustice
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 4 Nov 2022
Recorded in the Trade Register: 16 Nov 2022
Name: NORBERT TÓTH
Registration address: Slovensko, Komárno, Kameničná 751, 94601 Komárno, Slovensko
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 8 Nov 2022
Recorded in the Trade Register: 16 Nov 2022
Name: ANNA MATOUŠKOVÁ
Registration address: Česká republika, Praha, Osluněná 751, Lipence, 15531 Praha 5
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 10 Oct 2022
Recorded in the Trade Register: 16 Nov 2022
Name: ADAM ŠOTEK
Registration address: Česká republika, Opava, Sladkého 2155/12, Předměstí, 74601 Opava
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 3 Jan 2022
Recorded in the Trade Register: 17 Jan 2022

Authority to represent the legal entity

How members of this governing body can currently represent the legal entity:
  • Společnost zastupuje představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají vždy dva členové představenstva společně. (from 19 Aug 2019)

Managing board (Představenstvo), history of changes

Below, you will find the representatives of the Managing board (Představenstvo), who were previously appointed, as well as changes to their details.

Name: JIŘÍ RABIEC
Registration address: Česká republika, Ludgeřovice, Na Mokřinách 872/6, 74714 Ludgeřovice
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Jun 2023
Recorded in the Trade Register: 20 Jun 2023
Deleted from the Trade Register: 8 Dec 2023
Name: PETR SZUMA
Registration address: Česká republika, Tlustice, č.p. 310, 26801 Tlustice
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 4 Nov 2022
Recorded in the Trade Register: 16 Nov 2022
Deleted from the Trade Register: 16 Nov 2022
Name: DAVID VANDROVEC
Registration address: Česká republika, Praha, Bratislavská 1488/6, Hostivař, 10200 Praha 10
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Jan 2022
Recorded in the Trade Register: 17 Jan 2022
Deleted from the Trade Register: 16 Nov 2022
Name: BRANISLAV POSUCH
Registration address: Česká republika, Praha, Na Fialce II 1673/31, Řepy, 16300 Praha 6
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Dec 2021
Recorded in the Trade Register: 29 Dec 2021
Deleted from the Trade Register: 1 Nov 2022
Name: ADAM ŠOTEK
Registration address: Česká republika, Opava, Sladkého 2155/12, Předměstí, 74601 Opava
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 24 Jul 2019
Recorded in the Trade Register: 17 Feb 2020
Deleted from the Trade Register: 17 Jan 2022
Name: TOMÁŠ SCHMIED
Registration address: Česká republika, Ostrava, Budovatelská 450/9, Poruba, 70800 Ostrava
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 24 Jul 2019
Recorded in the Trade Register: 17 Feb 2020
Deleted from the Trade Register: 17 Jan 2022
Name: JAN KHÝR
Registration address: Česká republika, Lety, K lesíku 445, 25229 Lety
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Nov 2019
Recorded in the Trade Register: 7 Nov 2019
Deleted from the Trade Register: 4 Nov 2021
Name: JAROSLAV STRNAD
Registration address: Česká republika, Slatiňany, Tyršova 816, 53821 Slatiňany
Appointment date: 24 Jul 2019
Recorded in the Trade Register: 19 Aug 2019
Deleted from the Trade Register: 7 Nov 2019
Name: ADAM ŠOTEK
Registration address: Česká republika, Opava, Sladkého 2155/12, Předměstí, 74601 Opava
Appointment date: 24 Jul 2019
Recorded in the Trade Register: 19 Aug 2019
Deleted from the Trade Register: 17 Feb 2020
Name: TOMÁŠ SCHMIED
Registration address: Česká republika, Ostrava, Budovatelská 450/9, Poruba, 70800 Ostrava
Appointment date: 24 Jul 2019
Recorded in the Trade Register: 19 Aug 2019
Deleted from the Trade Register: 17 Feb 2020

Abolished governing bodies and their representatives

Below you will find information about the abolished governing bodies of the legal entity CE Power Industries a.s. and their representatives. These are governing bodies that were previously established in the company but have now been dissolved and are no longer part of the management structure.

Director (Statutární ředitel), abolished

A governing body of a Czech legal entity with the authority to represent the legal entity in all matters and in full capacity.

Existed from 26 Feb 2018 to 19 Aug 2019
Former number of members in the body: 1 (from 26 Feb 2018 to 19 Aug 2019)
Name: JAROSLAV STRNAD
Registration address: Česká republika, Slatiňany, Tyršova 816, 53821 Slatiňany
Position in the governing body: Statutární ředitel
Appointment date: 26 Feb 2018
Date of termination from office: 24 Jul 2019
Recorded in the Trade Register: 26 Feb 2018
Deleted from the Trade Register: 19 Aug 2019

Additional information regarding this governing body from the past years

Provisions that previously applied to this governing body but are no longer valid.

How members of this governing body could previously represent the legal entity:
  • Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně (from 26 Feb 2018 to 19 Aug 2019)

Managing board (Představenstvo), abolished

(Czech "Představenstvo") - is the governing body of a legal entity.
Existed from 22 Dec 2017 to 26 Feb 2018
Former number of members in the body: 2 (from 22 Dec 2017 to 26 Feb 2018)
Name: MICHAL STRNAD
Registration address: Česká republika, Slatiňany, Tyršova 816, 53821 Slatiňany
Position in the governing body: Předseda představenstva
Appointment date: 22 Dec 2017
Date of termination from office: 26 Feb 2018
Recorded in the Trade Register: 22 Dec 2017
Deleted from the Trade Register: 26 Feb 2018
Name: ILONA KADLECOVÁ
Registration address: Česká republika, Ráby, č.p. 101, 53352 Ráby
Position in the governing body: Člen představenstva
Appointment date: 22 Dec 2017
Recorded in the Trade Register: 22 Dec 2017
Deleted from the Trade Register: 26 Feb 2018

Additional information regarding this governing body from the past years

Provisions that previously applied to this governing body but are no longer valid.

How members of this governing body could previously represent the legal entity:
  • Společnost zastupuje představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva. (from 22 Dec 2017 to 26 Feb 2018)

Shares of the legal entity (current, actual)

Information about currently issued shares, their quantity, and type (typically applicable to legal entities structured as joint-stock companies).
Currently active/issued shares:
  • from 29 Mar 2023 - Quantity: 1 issued shares , value per share 105 263 Czech crowns , Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Form of shares: Physical shares (exist in physical form)
  • from 22 Dec 2017 - Quantity: 20 issued shares , value per share 100 000 Czech crowns , Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights) , Form of shares: Physical shares (exist in physical form)

No changes in share issuance have occurred

The quantity, type, and form of shares in the legal entity have remained unchanged. This situation is entirely possible.

Supervisory Board (Dozorčí rada), current representatives

(Czech "Dozorčí rada") - is a supervisory board in many Czech legal entities.

Name: JAROSLAV STRNAD
Registration address: Česká republika, Chrudim, Široká 129, Chrudim I, 53701 Chrudim
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 27 Jan 2020
Recorded in the Trade Register: 11 Nov 2022

Changes history of Supervisory Board representatives

Former representatives of the Supervisory Board (Dozorčí rada) and changes to their details

Name: JAROSLAV STRNAD
Registration address: Česká republika, Slatiňany, Tyršova 816, 53821 Slatiňany
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 27 Jan 2020
Recorded in the Trade Register: 17 Feb 2020
Deleted from the Trade Register: 11 Nov 2022
Name: LUMÍR SWIECH
Registration address: Česká republika, Ostrava, Jana Maluchy 25/2, Dubina, 70030 Ostrava
Appointment date: 24 Jul 2019
Recorded in the Trade Register: 19 Aug 2019
Deleted from the Trade Register: 17 Feb 2020

Administrative Board (Správní rada), abolished

(Czech "Správní rada") - is a legal entity’s body combining both managerial and supervisory functions.

Existed from 26 Feb 2018 to 19 Aug 2019
Name: JAROSLAV STRNAD
Registration address: Česká republika, Slatiňany, Tyršova 816, 53821 Slatiňany
Position: Člen správní rady
Appointment date: 26 Feb 2018
Date of termination from position: 24 Jul 2019
Recorded in the Trade Register: 26 Feb 2018
Deleted from the Trade Register: 19 Aug 2019

Supervisory Board (Dozorčí rada), abolished

This legal entity previously had a Supervisory Board (Dozorčí rada), which has now been abolished or modified. However, you can still view information about the former representatives of the Supervisory Board who were appointed in the past.

Existed from 22 Dec 2017 to 26 Feb 2018
Name: DALIBOR VÁŇA
Registration address: Česká republika, Hradec Králové, třída SNP 635/24, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
Position: Předseda dozorčí rady
Appointment date: 22 Dec 2017
Date of termination from position: 26 Feb 2018
Recorded in the Trade Register: 22 Dec 2017
Deleted from the Trade Register: 26 Feb 2018
Name: HANA ADAMCOVÁ
Registration address: Česká republika, Třebechovice pod Orebem, Družstevní práce 862, 50346 Třebechovice pod Orebem
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 22 Dec 2017
Recorded in the Trade Register: 22 Dec 2017
Deleted from the Trade Register: 26 Feb 2018

Shareholders (Akcionář),current, actual

Unfortunately, it is not always possible to identify the shareholders of a Czech legal entity. Information about them is often hidden in the company's internal records.

Shareholders, current

Individuals currently holding shares in the legal entity.

No current representatives found

This means that this type of corporate body is established in the legal entity, but currently has no appointed active representatives, which is a possible situation. You can view previous representatives by clicking the button to show the full history of changes.

Shareholder history

Former shareholders of the legal entity. This information is not always available, as the legislation of the Czech Republic allows the legal entities to hide this information in the internal documents (for example for joint-stock companies). Nevertheless, we will still try to identify them.

Name: STRNAD HOLDING LTD
Registration address: Kypr, Nikózie, Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, 1061 Nikózie, Kypr
Recorded in the Trade Register: 16 May 2018
Deleted from the Trade Register: 30 Mar 2023
Name: JAROSLAV STRNAD
Registration address: Česká republika, Slatiňany, Tyršova 816, 53821 Slatiňany
Recorded in the Trade Register: 26 Feb 2018
Deleted from the Trade Register: 16 May 2018
Name: CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
Verify data
Registration number (IČO): 03472302
Registration address: Česká republika, Praha, Sokolovská 675/9, Karlín, 18600 Praha 8
Recorded in the Trade Register: 22 Dec 2017
Deleted from the Trade Register: 26 Feb 2018

Business activities/licences of company CE Power Industries a.s.

In this section, you will find information about all types of activities/licences of the legal entity CE Power Industries a.s., both currently active and previously registered. Please note that in the Czech Republic, business activities are initially recorded in the company's Articles of Association (usually in general terms) but must also be registered with the Trade Licensing Office (živnostenský úřad in Czech), where more specific, individual licenses of the legal entity are recorded. Below, we provide data from both sources. Unfortunately, the information is currently available only in the Czech language. For translation, please use your browser's built-in translation tool..

Actual business activites by the of Articles of Association

These are the types of business activities originally defined in the company's Articles of Association, actual to this moment.

  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (from 23 Jun 2023)
  • Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy (from 23 Jun 2023)
  • Správa vlastního majetku (from 19 Aug 2019)

History of changes business activites by Articles of Association

Types of activities previously listed in the Articles of Association of the company CE Power Industries a.s., but no longer active (removed from the Articles of Association):

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (from 22 Dec 2017 to 23 Jun 2023)

Current business activities/licences of per Trade Licensing Office

Current types of activities of the company CE Power Industries a.s. as issued by the Trade Licensing Office of the Czech Republic ("živnostenský úřad" in Czech).

No current licenses issued by the Trade Licensing Office of the Czech Republic have been found.

History of business activities of per Trade Licensing Office

Previously registered business activities of CE Power Industries a.s. issued by Trade Licensing Office (živnostenský úřad), which are no longer valid.

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (from 22 Dec 2017 to 1 Jan 2024)
  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (from 19 Jan 2021 to 1 Jan 2024)

Additional Information about the legal entity

Any other data that has been entered into the company's charter or recorded in the Trade Register. Unfortunately, this information is currently available only in the Czech language. For translation, please use your browser's built-in translation tool.

Currently registered records

Records that are valid at the present time:

  • Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: (i) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 105.263,- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc dvě stě šedesát tři korun českých), tj. z částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 2.105.263,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto pět tisíc dvě stě šedesát tři korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nové akcie, přičemž nově bude vydána akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: - 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 105.263,- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc dvě stě šedesát tři korun českých); Druh akcie: - zvláštní akcie, se kterými budou spojena tato zvláštní práva: - právo na přednostní podíl na zisku na Společnosti (dividendu), a to do roku 2024 (slovy: dva tisíce dvacet čtyři) ve výši určené valnou hromadou, minimálně však ve výši 2,5 % (slovy: dvě celá pět desetin procenta) celkové výše konsolidovaného zisku dosaženého Společností a společnostmi, které patří do konsolidačního celku, do něhož patří Společnost (bez ohledu na to, zda Společnost bude konsolidující účetní jednotkou), v předchozím účetním ob-dobí, a to i v případě, že z rozhodnutí valné hromady nebude mezi majitele ostatních akcií rozdělena žádná část zisku, - zvláštní akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady, - se zvláštní akcií není spojeno hlasovací právo, vyjma hlasovacího práva při rozhodování valné hromady o změně práv související se zvláštní akcií nebo kde to stanové zákon a v takovém případě je se zvláštní akcií spojen jeden hlas, - v ostatních ohledech jsou se zvláštní akcií spojena stejná práva jako s kmenovými akciemi (včetně práva na podíl na zisku a jiném rozdělování vlastního kapitálu ve výši 5 %); Podoba akcie: - akcie bude vydána jako listinný cenný papír; Forma akcie: - akcie na jméno; (dále též jen Upisovaná akcie) (iii) Jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování Upisované akcie výslovně vzdal v rozsahu celého svého podílu, tj. v rozsahu 100%, a Upisovaná akcie tak nebude upisována s využitím přednostního práva. (iv) Upisovaná akcie bude nabídnuta k upsání určenému zájemci, a to panu Adamu Šotkovi, datum narození 6.9.1977, pobyt Opava, Předměstí, Sladkého 2155/12 (dále jen Zájemce). Upisovaná akcie bude upsána písemnou smlouvou o úpisu Upisované akcie, která bude uzavřena mezi Zájemcem a Společností, a to s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu Upisované akcie musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Upisovaná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. (vi) Upisovací lhůta činí 30 (slovy: třicet) dní ode dne přijetí tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Návrh smlouvy o úpisu Upisované akcie musí obsahovat údaje dle ust.§ 479 zákona o obchodních korporacích; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Upisované akcie je představenstvo Společnosti povinno doručit Zájemci nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti, spolu s upozorněním pro Zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Upisované akcie s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Upisované akcie dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Upisované akcie Zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (vii) Emisní kurs Upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tak 105.263,- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc dvě stě šedesát tři korun českých). Emisní kurs Upisované akcie bude splacen výlučně peněžitým vkladem. (viii) Účtem u banky, na který je Zájemce povinen splatit emisní kurs Upisované akcie, je bankovní účet Společnosti 6368145002/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. (ix) Lhůta pro splacení emisního kursu Upisované akcie činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne, kdy Zájemce doručí smlouvu o úpisu Upisované akcie Společnosti se všemi náležitostmi dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a dle zákona o obchodních korporacích. (date of record 29 Mar 2023)
CHANGE HISTORY: The additional information for this legal entity has never been changed; there are no historical records.