Extract for the legal entity CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (IČO: 03472302)

Date and time of the extract: 14 Dec 2025, 22:30 (Prague time)*
NEW SEARCH

Basic information

Company name: CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (from 14 Jan 2016)
- Previous name - EXCALIBUR GROUP a.s. (from 13 Oct 2014 to 14 Jan 2016)
Registration number (IČO): 03472302
Tax identification number (Tax ID, "DIČ" in Czech): CZ03472302
Date of establishment/registration: 13 Oct 2014
- Registration number (IČO), tax ID (DIČ) and registration date are permanent data of the Czech legal entity and do not change
Legal address: Česká republika, Praha, U Rustonky 714/1, Karlín, 18600 Praha 8 (from 1 Apr 2024)
- Previously - Česká republika, Praha, Pernerova 691/42, Karlín, 18600 Praha 8 (from 6 Oct 2020 to 1 Apr 2024)
- Previously - Česká republika, Praha, Sokolovská 675/9, Karlín, 18600 Praha 8 (from 13 Jan 2016 to 6 Oct 2020)
- Previously - Česká republika, Praha, Kodaňská 521/57, Vršovice, 10100 Praha 10 (from 13 Oct 2014 to 13 Jan 2016)
Share capital: 2 000 000 000 Czech crowns , paid on 100 percents (from 28 Jun 2021)
- Previously - 2 000 000 Czech crowns (from 13 Oct 2014 to 28 Jun 2021)
Legal form: Joint-stock company, stock corporation ("a.s.") (from 13 Oct 2014)
- The legal form capital has not changed
Company status (Good standing): Legal entity is active
- Tracking changes to the company's status is very hard – please refer to the notes on company name changes for clarity.
Registering authority: Court MSPH, section B, archive number 20071 (from 13 Oct 2014)
- The registering authority has not changed

Governing bodies and their representatives (current, active)

In the sections below, you will find information about the currently active governing bodies of the legal entity CZECHOSLOVAK GROUP a.s. and the appointed representatives in each body.

Managing board (Představenstvo), current representatives

Number of members in this governing body currently defined by the charter: 7 (from 1 Oct 2025)
- Previously - number of members: 5 (from 25 Feb 2025 to 1 Oct 2025)
- Previously - number of members: 7 (from 1 Jan 2024 to 25 Feb 2025)
- Previously - number of members: 5 (from 6 Sep 2022 to 1 Jan 2024)
- Previously - number of members: 4 (from 20 Apr 2022 to 6 Sep 2022)
- Previously - number of members: 5 (from 1 Sep 2020 to 20 Apr 2022)
- Previously - number of members: 3 (from 13 Oct 2014 to 1 Sep 2020)
Name: ALENA KOZÁKOVÁ
Registration address: Česká republika, Studénka, Malá strana 685, Butovice, 74213 Studénka
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Oct 2025
Recorded in the Trade Register: 1 Oct 2025
Name: MICHAELA KATOLICKÁ
Registration address: Česká republika, Makotřasy, č.p. 156, 27354 Makotřasy
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Oct 2025
Recorded in the Trade Register: 1 Oct 2025
Name: DAVID CHOUR
Registration address: Česká republika, Chrudim, Břetislavova 71, Chrudim I, 53701 Chrudim
Position in the governing body: místopředseda představenstva
Appointment date: 2 Sep 2025
Recorded in the Trade Register: 2 Sep 2025
Name: PETR FORMÁNEK
Registration address: Česká republika, České Lhotice, Hradiště 5, 53825 České Lhotice
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 5 Nov 2024
Recorded in the Trade Register: 20 Feb 2025
Name: MICHAL STRNAD
Registration address: Česká republika, Chrudim, Široká 129, Chrudim I, 53701 Chrudim
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 2 Oct 2024
Recorded in the Trade Register: 20 Feb 2025
Name: LADISLAV ŠTOREK
Registration address: Česká republika, Praha, Nad Rokoskou 1228/38, Libeň, 18200 Praha 8
Position in the governing body: místopředseda představenstva
Appointment date: 1 Jan 2024
Recorded in the Trade Register: 12 Jan 2024
Name: ZDENĚK JURÁK
Registration address: Česká republika, Praha, Nuselská 1754/53a, Nusle, 14000 Praha 4
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Jan 2024
Recorded in the Trade Register: 1 Jan 2024

Authority to represent the legal entity

How members of this governing body can currently represent the legal entity:
  • Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Pokud předseda ani žádný místopředseda představenstva nejsou zvoleni, zastupují společnost ve všech záležitostech vždy dva členové představenstva. (from 20 Apr 2022)

Managing board (Představenstvo), history of changes

Below, you will find the representatives of the Managing board (Představenstvo), who were previously appointed, as well as changes to their details.

Name: LUKÁŠ ANDRÝSEK
Registration address: Česká republika, Třinec, Beskydská 730, Lyžbice, 73961 Třinec
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Jan 2024
Recorded in the Trade Register: 1 Jan 2024
Deleted from the Trade Register: 20 Feb 2025
Name: LADISLAV ŠTOREK
Registration address: Česká republika, Praha, Nad Rokoskou 1228/38, Libeň, 18200 Praha 8
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Sep 2022
Recorded in the Trade Register: 6 Sep 2022
Deleted from the Trade Register: 12 Jan 2024
Name: MICHAL STRNAD
Registration address: Česká republika, Chrudim, Široká 129, Chrudim I, 53701 Chrudim
Position in the governing body: Předseda představenstva
Appointment date: 1 Oct 2019
Date of termination from office: 1 Oct 2024
Recorded in the Trade Register: 31 Jul 2022
Deleted from the Trade Register: 20 Feb 2025
Name: DAVID ŠTĚPÁN
Registration address: Česká republika, Praha, Zaječická 836/9, Čimice, 18400 Praha 8
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Mar 2022
Recorded in the Trade Register: 14 Mar 2022
Deleted from the Trade Register: 25 Feb 2025
Name: MIROSLAV DORŇÁK
Registration address: Česká republika, Předboj, V Dolině 393, 25072 Předboj
Position in the governing body: místopředseda představenstva
Appointment date: 1 Sep 2020
Date of termination from office: 28 Feb 2022
Recorded in the Trade Register: 1 Sep 2020
Deleted from the Trade Register: 14 Mar 2022
Name: DAVID CHOUR
Registration address: Česká republika, Chrudim, Břetislavova 71, Chrudim I, 53701 Chrudim
Position in the governing body: místopředseda představenstva
Appointment date: 1 Sep 2020
Date of termination from office: 1 Sep 2025
Recorded in the Trade Register: 1 Sep 2020
Deleted from the Trade Register: 2 Sep 2025
Name: PETR FORMÁNEK
Registration address: Česká republika, České Lhotice, Hradiště 5, 53825 České Lhotice
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 4 Nov 2019
Recorded in the Trade Register: 27 Nov 2019
Deleted from the Trade Register: 20 Feb 2025
Name: MICHAL STRNAD
Registration address: Česká republika, Slatiňany, Tyršova 816, 53821 Slatiňany
Position in the governing body: Předseda představenstva
Appointment date: 1 Oct 2019
Recorded in the Trade Register: 21 Oct 2019
Deleted from the Trade Register: 31 Jul 2022
Name: ILONA KADLECOVÁ
Registration address: Česká republika, Ráby, č.p. 101, 53352 Ráby
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 1 Oct 2019
Recorded in the Trade Register: 21 Oct 2019
Deleted from the Trade Register: 21 Jan 2021
Name: PETR RUSEK
Registration address: Česká republika, Opatovec, č.p. 97, 56802 Opatovec
Position in the governing body: Člen představenstva
Appointment date: 22 Apr 2016
Recorded in the Trade Register: 30 May 2016
Deleted from the Trade Register: 27 Nov 2019
Name: ILONA KADLECOVÁ
Registration address: Česká republika, Ráby, č.p. 101, 53352 Ráby
Position in the governing body: Člen představenstva
Appointment date: 13 Oct 2014
Recorded in the Trade Register: 13 Jan 2016
Deleted from the Trade Register: 21 Oct 2019
Name: MICHAL STRNAD
Registration address: Česká republika, Slatiňany, Tyršova 816, 53821 Slatiňany
Position in the governing body: Předseda představenstva
Appointment date: 31 Oct 2015
Date of termination from office: 30 Sep 2019
Recorded in the Trade Register: 13 Jan 2016
Deleted from the Trade Register: 21 Oct 2019
Name: ILONA KADLECOVÁ
Registration address: Česká republika, Ráby, č.p. 101, 53352 Ráby
Position in the governing body: předseda představenstva
Appointment date: 13 Oct 2014
Date of termination from office: 31 Oct 2015
Recorded in the Trade Register: 13 Oct 2014
Deleted from the Trade Register: 13 Jan 2016
Name: PETR NĚMEC
Registration address: Česká republika, Kosov, č.p. 17, 78901 Kosov
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 13 Oct 2014
Recorded in the Trade Register: 13 Oct 2014
Deleted from the Trade Register: 13 Jan 2016
Name: PETR KRATOCHVÍL
Registration address: Česká republika, Mikulovice, Na Kopci 194, 53002 Mikulovice
Position in the governing body: člen představenstva
Appointment date: 13 Oct 2014
Recorded in the Trade Register: 13 Oct 2014
Deleted from the Trade Register: 14 Jan 2016

Additional information regarding this governing body from the past

Provisions that previously applied to this governing body but are no longer valid

How members of this governing body could previously represent the legal entity:
  • Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani žádný místopředseda představenstva nejsou zvoleni, zastupují společnost ve všech záležitostech vždy dva členové představenstva. (from 1 Sep 2020 to 20 Apr 2022)
  • Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva. (from 13 Oct 2014 to 1 Sep 2020)

Shares of the legal entity (current, actual)

Information about currently issued shares, their quantity, and type (typically applicable to legal entities structured as joint-stock companies).
Currently active/issued shares:
  • from 28 Jun 2021 - Quantity: 20 issued shares , value per share 100 000 000 Czech crowns , Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Form of shares: Book-entry shares (recorded in the company’s register, no separate paper form)

Share issuance history of the legal entity

Information about previously issued shares of the legal entity.
Share issuance history:
  • from 8 Nov 2016 to 28 Jun 2021 - Quantity: 20 issued shares , value per share 100 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Common shares (Czech: "Kmenové", providing profit and full voting rights) , Form of shares: Book-entry shares (recorded in the company’s register, no separate paper form)
  • from 13 Oct 2014 to 8 Nov 2016 - Quantity: 20 issued shares , value per share 100 000 Czech crowns, Type of shares: Registered shares (Czech: "Akcie na jméno", registered to a specific person) , Form of shares: Physical shares (exist in physical form)

Supervisory Board (Dozorčí rada), current representatives

(Czech "Dozorčí rada") - is a supervisory board in many Czech legal entities.

Name: ZUZANA SLOVÁKOVÁ
Registration address: Česká republika, Zádveřice-Raková, Zádveřice 361, 76312 Zádveřice-Raková
Position: předseda dozorčí rady
Appointment date: 1 Oct 2025
Recorded in the Trade Register: 1 Oct 2025
Name: ALEŠ KLEPEK
Registration address: Česká republika, Horoměřice, Žižkova 1127, 25262 Horoměřice
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 3 Sep 2025
Recorded in the Trade Register: 4 Sep 2025
Name: RUDOLF BUREŠ
Registration address: Česká republika, Praha, Jindřišská 875/23, Nové Město, 11000 Praha 1
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 5 Oct 2023
Recorded in the Trade Register: 19 Mar 2024

Changes history of Supervisory Board representatives

Former representatives of the Supervisory Board (Dozorčí rada) and changes to their details

Name: ALEŠ KLEPEK
Registration address: Česká republika, Praha, Kamýcká 243/4, Sedlec, 16000 Praha 6
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 3 Sep 2025
Recorded in the Trade Register: 3 Sep 2025
Deleted from the Trade Register: 4 Sep 2025
Name: ALEŠ KLEPEK
Registration address: Česká republika, Horoměřice, Žižkova 1127, 25262 Horoměřice
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 2 Sep 2020
Recorded in the Trade Register: 8 Aug 2025
Deleted from the Trade Register: 3 Sep 2025
Name: MICHAELA KATOLICKÁ
Registration address: Česká republika, Makotřasy, č.p. 156, 27354 Makotřasy
Position: předseda dozorčí rady
Appointment date: 1 Jan 2024
Date of termination from position: 1 Oct 2025
Recorded in the Trade Register: 12 Jan 2024
Deleted from the Trade Register: 1 Oct 2025
Name: MICHAELA KATOLICKÁ
Registration address: Česká republika, Makotřasy, č.p. 156, 27354 Makotřasy
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 1 Mar 2023
Recorded in the Trade Register: 13 Apr 2023
Deleted from the Trade Register: 12 Jan 2024
Name: ALEŠ KVÍDERA
Registration address: Česká republika, Živanice, č.p. 231, 53342 Živanice
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 14 Apr 2022
Recorded in the Trade Register: 20 Apr 2022
Deleted from the Trade Register: 13 Apr 2023
Name: ALEŠ KLEPEK
Registration address: Česká republika, Praha, Kamýcká 243/4, Sedlec, 16000 Praha 6
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 2 Sep 2020
Recorded in the Trade Register: 10 Sep 2020
Deleted from the Trade Register: 8 Aug 2025
Name: MARIÁN GOGA
Registration address: Slovensko, Nováky, Partizánská 1471/28, Nováky, Slovensko
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 4 Nov 2019
Recorded in the Trade Register: 27 Nov 2019
Deleted from the Trade Register: 10 Sep 2020
Name: TOMÁŠ HASMAN
Registration address: Česká republika, Praha, Tusarova 1235/32, Holešovice, 17000 Praha 7
Position: předseda dozorčí rady
Appointment date: 4 Nov 2019
Date of termination from position: 14 Apr 2022
Recorded in the Trade Register: 27 Nov 2019
Deleted from the Trade Register: 20 Apr 2022
Name: TOMÁŠ HASMAN
Registration address: Česká republika, Praha, Tusarova 1235/32, Holešovice, 17000 Praha 7
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 1 Sep 2019
Recorded in the Trade Register: 18 Sep 2019
Deleted from the Trade Register: 27 Nov 2019
Name: RUDOLF BUREŠ
Registration address: Česká republika, Praha, Jindřišská 875/23, Nové Město, 11000 Praha 1
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 4 Oct 2018
Recorded in the Trade Register: 15 Oct 2018
Deleted from the Trade Register: 19 Mar 2024
Name: MARTIN VRECION
Registration address: Česká republika, Ondřejov, Větrná 405, 25165 Ondřejov
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 4 Oct 2018
Recorded in the Trade Register: 15 Oct 2018
Deleted from the Trade Register: 18 Sep 2019
Name: JAROSLAV STRNAD
Registration address: Česká republika, Slatiňany, Tyršova 816, 53821 Slatiňany
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 11 Jan 2016
Recorded in the Trade Register: 14 Jan 2016
Deleted from the Trade Register: 27 Nov 2019
Name: TOMÁŠ HASMAN
Registration address: Česká republika, Praha, Poupětova 869/10, Holešovice, 17000 Praha 7
Position: Člen dozorčí rady
Appointment date: 31 Oct 2015
Recorded in the Trade Register: 13 Jan 2016
Deleted from the Trade Register: 14 Jan 2016
Name: DALIBOR VÁŇA
Registration address: Česká republika, Hradec Králové, třída SNP 635/24, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 13 Oct 2014
Recorded in the Trade Register: 25 Feb 2015
Deleted from the Trade Register: 14 Jan 2016
Name: MICHAL STRNAD
Registration address: Česká republika, Slatiňany, Tyršova 816, 53821 Slatiňany
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 13 Oct 2014
Recorded in the Trade Register: 13 Oct 2014
Deleted from the Trade Register: 13 Jan 2016
Name: DALIBOR VÁŇA
Registration address: Česká republika, Hradec Králové, náměstí Jana Pavla II. 59/5, 50003 Hradec Králové
Position: člen dozorčí rady
Appointment date: 13 Oct 2014
Recorded in the Trade Register: 13 Oct 2014
Deleted from the Trade Register: 25 Feb 2015
Name: RADEK RŮŽIČKA
Registration address: Česká republika, Hlízov, č.p. 225, 28532 Hlízov
Position: předseda dozorčí rady
Appointment date: 13 Oct 2014
Date of termination from position: 11 Jan 2016
Recorded in the Trade Register: 13 Oct 2014
Deleted from the Trade Register: 14 Jan 2016

Shareholders (Akcionář),current, actual

Unfortunately, it is not always possible to identify the shareholders of a Czech legal entity. Information about them is often hidden in the company's internal records.

Shareholders, current

Individuals currently holding shares in the legal entity.

Name: CSG FIN a.s.
Verify data
Registration number (IČO): 14141442
Registration address: Česká republika, Praha, U Rustonky 714/1, Karlín, 18600 Praha 8
Recorded in the Trade Register: 3 Apr 2024

Shareholder history

Former shareholders of the legal entity. This information is not always available, as the legislation of the Czech Republic allows the legal entities to hide this information in the internal documents (for example for joint-stock companies). Nevertheless, we will still try to identify them.

Name: CSG FIN a.s.
Verify data
Registration number (IČO): 14141442
Registration address: Česká republika, Praha, Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 11000 Praha 1
Recorded in the Trade Register: 1 Feb 2023
Deleted from the Trade Register: 3 Apr 2024
Name: CSG FIN a.s.
Verify data
Registration number (IČO): 14141442
Registration address: Česká republika, Praha, Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 11000 Praha 1
Recorded in the Trade Register: 29 Jun 2022
Deleted from the Trade Register: 1 Feb 2023
Name: MICHAL STRNAD
Registration address: Česká republika, Slatiňany, Tyršova 816, 53821 Slatiňany
Recorded in the Trade Register: 31 Aug 2020
Deleted from the Trade Register: 29 Jun 2022
Name: Czechoslovak Group B.V.
Registration address: Nizozemsko, Amsterdam, Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Nizozemsko
Recorded in the Trade Register: 9 Nov 2016
Deleted from the Trade Register: 31 Aug 2020
Name: Czechoslovak Group B.V.
Registration address: Nizozemsko, Amsterdam, Kabelweg 37, 1014BA Amsterdam, Nizozemsko
Recorded in the Trade Register: 29 Dec 2015
Deleted from the Trade Register: 9 Nov 2016
Name: Excalibur Group B.V.
Registration address: Nizozemsko, Amsterdam, Kabelweg 37, 1014BA Amsterdam, Nizozemsko
Recorded in the Trade Register: 6 Jan 2015
Deleted from the Trade Register: 29 Dec 2015
Name: JAROSLAV STRNAD
Registration address: Česká republika, Slatiňany, Tyršova 816, 53821 Slatiňany
Recorded in the Trade Register: 13 Oct 2014
Deleted from the Trade Register: 6 Jan 2015

Business activities/licences of company CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

In this section, you will find information about all types of activities/licences of the legal entity CZECHOSLOVAK GROUP a.s., both currently active and previously registered. Please note that in the Czech Republic, business activities are initially recorded in the company's Articles of Association (usually in general terms) but must also be registered with the Trade Licensing Office (živnostenský úřad in Czech), where more specific, individual licenses of the legal entity are recorded. Below, we provide data from both sources. Unfortunately, the information is currently available only in the Czech language. For translation, please use your browser's built-in translation tool..

Actual business activites by the of Articles of Association

These are the types of business activities originally defined in the company's Articles of Association, actual to this moment.

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu oborů činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb; - Velkoobchod a maloobchod; - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; - Pronájem a půjčování věcí movitých; - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; - Poskytování technických služeb. (from 28 Jun 2021)
  • Správa vlastního majetku (from 29 Jun 2022)

History of changes business activites by Articles of Association

Types of activities previously listed in the Articles of Association of the company CZECHOSLOVAK GROUP a.s., but no longer active (removed from the Articles of Association):

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. (from 13 Oct 2014 to 28 Jun 2021)

Current business activities/licences of per Trade Licensing Office

Current types of activities of the company CZECHOSLOVAK GROUP a.s. as issued by the Trade Licensing Office of the Czech Republic ("živnostenský úřad" in Czech).

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (from 13 Oct 2014)
    • Pronájem a půjčování věcí movitých (from 13 Oct 2014)
    • Zprostředkování obchodu a služeb (from 13 Oct 2014)
    • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (from 13 Oct 2014)
    • Velkoobchod a maloobchod (from 13 Oct 2014)
    • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení (from 13 Oct 2014)
    • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály (from 13 Oct 2014)
    • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy (from 13 Oct 2014)
    • Poskytování technických služeb (from 13 Oct 2014)
    • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí (from 3 Mar 2020)
CHANGE HISTORY: The types of activities issued by the Trade Licensing Office ("živnostenský úřad" in Czech) for this legal entity have never been changed.

Additional Information about the legal entity

Any other data that has been entered into the company's charter or recorded in the Trade Register. Unfortunately, this information is currently available only in the Czech language. For translation, please use your browser's built-in translation tool.

Currently registered records

Records that are valid at the present time:

  • Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s., se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 034 72 302 (dále téže jen jako Společnost) takto: (i) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.998.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set devadesát osm milionů korun českých), tj. z částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých); (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ve smyslu ustanovení § 495 a násl. ZOK, a to z vlastních zdrojů Společnosti, tedy z ostatních fondů - ostatních kapitálových fondů, vykázaných v celkové výši 2.896.897.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osm set devadesát šest milionů osm set devadesát sedm tisíc korun českých) rozvahy, která je součástí řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2020 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), schválené jediným akcionářem dne 16.6.2021 a ověřené auditorem obchodní společností Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 496 20 592, statutární auditor David Batal, evidenční číslo: 2147; (iii) na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se tedy použije část shora uvedených ostatních kapitálových fondů ve výši 1.998.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set devadesát osm milionů korun českých); (iv) zvýšení základního kapitálu bude provedeno tak, že se zvýší jmenovitá hodnota stávajících akcií ve vlastnictví Jediného akcionáře Společnosti, a to tak, že u všech stávajících 20-ti ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) se zvýší jmenovitá hodnota každé akcie o částku 99.900.000,- (slovy: devadesát devět milionů devět set tisíc korun českých), tedy na částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých); (v) vzhledem k tomu, že všechny akcie ve Společnosti jsou v zaknihované podobě, bude zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií provedeno ve smyslu ust. § 501 ZOK, tedy ze strany Společnosti bude podán příkaz k provedení změny zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů. (date of record 28 Jun 2021)
  • Na společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03472302, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20071, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku přeshraniční fúze sloučením jmění společnosti Czechoslovak Group B.V., se sídlem v Amsterdamu, Nizozemské království, a s obchodní adresou Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod registračním číslem 61195456, jako společnosti zanikající. Rozhodným dnem přeshraniční fúze sloučením je 1.1.2020. (date of record 31 Aug 2020)
  • V souladu s projektem přeměny (projekt fúze sloučením) sepsaným dne 10.10.2016, vypracovaným statutárními orgány zúčastněných společností, a to společnosti LOGEKO a.s., se sídlem č.p. 101, 533 32 Čepí, identifikační číslo 013 82 080, jako zanikající společnosti se společností CZECHOSLOVAK GROUP a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 034 72 302, jako nástupnickou společností, ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu, podle něhož veškeré jmění zanikající společnosti LOGEKO a.s. přešlo na nástupnickou společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s.. Společnost LOGEKO a.s. zanikla bez likvidace. (date of record 21 Dec 2016)
  • Na základě fúze sloučením došlo k převodu jmění společnosti EXCALIBUR INDUSTRY a.s., se sídlem Kodaňská 521/57, Vršovice, 101 00 Praha 10, identifikační číslo 288 22 692 a společnosti EXCALIBUR ARMY CZ a.s., se sídlem Praha - Vršovice, Kodaňská 521/57, PSČ 101 00, identifikační číslo 259 75 072, jako zanikajících společností na nástupnickou společnost EXCALIBUR GROUP a.s., se sídlem Kodaňská 521/57, Vršovice, 101 00 Praha 10, identifikační číslo 034 72 302. (date of record 29 Dec 2015)
CHANGE HISTORY: The additional information for this legal entity has never been changed; there are no historical records.